WASELEY TWELVE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | WASELEY TWELVE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00440983 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WASELEY TWELVE LIMITED ?
Adresse du siège social | 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WASELEY TWELVE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2008 |
Quels sont les derniers dépôts pour WASELEY TWELVE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
État du capital au 12 mai 2010
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 15 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Jon William Mortimore le 03 févr. 2010 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Guy Paul Cuthbert Parsons le 03 févr. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Victor Harvey le 03 févr. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Grant David Hearn le 03 févr. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Jon William Mortimore le 03 févr. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 5 pages | 363a | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2006 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288c | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 403a | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288b |
Qui sont les dirigeants de WASELEY TWELVE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORTIMORE, Jon William | Secrétaire | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | British | Company Director | 93906210001 | |||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
HARVEY, Paul Victor | Administrateur | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 116809270002 | ||||
HEARN, Grant David | Administrateur | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | England | British | Company Director | 88628480002 | ||||
MORTIMORE, Jon William | Administrateur | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 93906210001 | ||||
PARSONS, Guy Paul Cuthbert | Administrateur | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 102187770002 | ||||
HICKS, Christopher Michael | Secrétaire | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | Accountant | 53932930001 | |||||
JACKSON, Kevin David | Secrétaire | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | British | 141586330001 | ||||||
MASON, Timothy Charles | Secrétaire | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||
MILLS, John Michael | Secrétaire | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||
TAUTZ, Helen Jane | Secrétaire | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||
WILSON, Paul James | Secrétaire | 47 Wordsworth Drive SM3 8HE Cheam Surrey | British | 767650001 | ||||||
FORTE NOMINEES LIMITED | Secrétaire | 166 High Holborn WC1V 6TT London | 42198970001 | |||||||
CHIANDETTI, Gian Battista | Administrateur | Daneswood Monks Walk SL5 9AZ South Ascot Berkshire | Italian | Catering Services Director | 35071680001 | |||||
CLACK, Peter Melvyn | Administrateur | Wagtails 63 Furze Hill Road GU35 8HA Headley Down Hampshire | British | Finance Director | 7668050004 | |||||
FORTE, Lillian Edith Mary | Administrateur | 6 The Grove 9 Balcombe Road Branksome Park BH13 6DX Poole Dorset | British | Chairman | 16707050002 | |||||
HICKS, Christopher Michael | Administrateur | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | Accountant | 53932930001 | |||||
JACKSON, Kevin David | Administrateur | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | England | British | Property Director | 141586330001 | ||||
MONNICKENDAM, Anthony Louis | Administrateur | Auburn House 39 High Street MK46 4EB Olney Buckinghamshire | United Kingdom | British | Managing Director | 1013880003 | ||||
RUSSELL, Thomas | Administrateur | 91 Lauderdale Tower EC2Y 8BY London | British | Chartered Secretary | 206020001 | |||||
SMALL, Jeremy Peter | Administrateur | Cherry Trees West Heath GU24 0JQ Pirbright Surrey | England | British | Company Secretary | 67168210001 | ||||
TURL, Simon Charles | Administrateur | Arden House Eastwell Road LE14 4SS Scalford Leicestershire | British | Director | 80261230001 | |||||
TURNER, Harry | Administrateur | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | Chief Operating Officer | 166789700001 | ||||
FORTE (UK) LIMITED | Administrateur | 166 High Holborn WC1V 6TT London | 42204690001 | |||||||
TRAVELREST SERVICES LIMITED | Administrateur | Parklands Court 24 Parklands Birmingham Great Park Rubery B45 9PZ Birmingham West Midlands | 42204690005 |
WASELEY TWELVE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Security accession deed | Créé le 04 févr. 2003 Livré le 12 févr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All that property situated at kendrick street, warrington. All that property situated at 1 midpoint, dick lane, pudsey, bradford. All that property situated at riverside, nottingham. For further details of all property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 28 févr. 1955 Livré le 11 mars 1955 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due etc. | |
Brèves mentions 4, 6 & 8 exeter road bournemouth hants. Together with all fixtures both present & future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0