MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED

MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00492179
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    32-38 Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 janv. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Amanda Claire Fogg en tant que secrétaire le 04 mai 2018

    1 pagesTM02
    X76N6ME1

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 19 oct. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    X5IV47DF

    Comptes pour une société dormante établis au 30 janv. 2016

    4 pagesAA
    L5HH4WCJ

    Changement d'adresse du siège social de 46 Colebrooke Row London N1 8AF à 32-38 Scrutton Street London EC2A 4RQ le 17 mai 2016

    1 pagesAD01
    X575I0QR

    Cessation de la nomination de Tim Morgan Davies en tant que directeur le 08 avr. 2016

    1 pagesTM01
    X54OE42W

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2015

    4 pagesAA
    L4J4DPMO

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 nov. 2015

    État du capital au 09 nov. 2015

    • Capital: GBP 262,500
    SH01
    X4JSF41S

    Cessation de la nomination de Teresa Tideman en tant que directeur le 23 avr. 2015

    1 pagesTM01
    X463SSS0

    Nomination de Mr Tim Davies en tant qu'administrateur le 23 avr. 2015

    2 pagesAP01
    X463SSXV

    Nomination de Mr Shaun Simon Wills en tant qu'administrateur le 23 avr. 2015

    2 pagesAP01
    X463SM9L

    Cessation de la nomination de Joanne Clare Bennett en tant que directeur le 23 avr. 2015

    1 pagesTM01
    X4619UIP

    Comptes pour une société dormante établis au 25 janv. 2014

    4 pagesAA
    L3JNU5KX

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 oct. 2014

    État du capital au 24 oct. 2014

    • Capital: GBP 262,500
    SH01
    X3J6FXBF

    Nomination de Joanne Clare Bennett en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    X30X9GYR

    Cessation de la nomination de Ian Johnson en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X30PM5XV

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 nov. 2013

    État du capital au 15 nov. 2013

    • Capital: GBP 262,500
    SH01
    X2L6MIPV

    Comptes pour une société dormante établis au 26 janv. 2013

    4 pagesAA
    L2JQCTTS

    Nomination de Mrs Amanda Claire Fogg en tant que secrétaire

    1 pagesAP03
    X2H2T8KH

    Cessation de la nomination de Philip Watt en tant que secrétaire

    1 pagesTM02
    X2H05IER

    Nomination de Ms Teresa Tideman en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    X28J3ZIR

    Cessation de la nomination de Sarah Morris en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X28J3YGA

    Comptes pour une société dormante établis au 28 avr. 2012

    4 pagesAA
    A20U5FO9

    Qui sont les dirigeants de MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILLS, Shaun Simon
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    Administrateur
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer185717270001
    ALSOP, Patricia Mary
    32 Nicosia Road
    SW18 3RN London
    Secrétaire
    32 Nicosia Road
    SW18 3RN London
    British501920002
    BRYAN, Paul Anthony Edward Peter
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    Secrétaire
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    BritishCompany Secretary25267050001
    CASH, Daphne Valerie
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary59646330005
    FABIAN, Andrew Mark
    139 Woodwarde Road
    SE22 8UP London
    Secrétaire
    139 Woodwarde Road
    SE22 8UP London
    BritishAccountant61022990001
    FINLAY, David Michael Gordon
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    Secrétaire
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    British68232410001
    FOGG, Amanda Claire
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    Secrétaire
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    181382590001
    HAUGHTON, Adrian Paul
    Brambles The Old Pitch
    Tirley
    GL19 4ET Gloucester
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Brambles The Old Pitch
    Tirley
    GL19 4ET Gloucester
    Gloucestershire
    BritishFinance Dir50089840002
    HEARD, Nicholas James
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    Secrétaire
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    BritishCompany Secretary132971860002
    JOHNSON, Ian Paul
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    Secrétaire
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    British76187110001
    KNIGHT, David Harper
    Lower Westfield House Westfield Lane
    Draycott
    BS27 3TN Cheddar
    Somerset
    Secrétaire
    Lower Westfield House Westfield Lane
    Draycott
    BS27 3TN Cheddar
    Somerset
    British67491150001
    WARBURTON, Jenny
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    Secrétaire
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    156850590001
    WATT, Philip Graham
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    Secrétaire
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    164008630001
    ALLEN, Paul Christopher
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    Administrateur
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    United KingdomIrishExecutive Director185112730001
    ALSOP, Patricia Mary
    32 Nicosia Road
    SW18 3RN London
    Administrateur
    32 Nicosia Road
    SW18 3RN London
    BritishSolicitor501920002
    BENNETT, Joanne Clare
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    Administrateur
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    EnglandBritishChief Finance Officer184759270001
    BRYAN, Paul Anthony Edward Peter
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    Administrateur
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    BritishCompany Secretary25267050001
    CASH, Daphne Valerie
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary59646330005
    CHADWICK, Allan
    32 Chamberlain Way
    HA5 2AX Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    32 Chamberlain Way
    HA5 2AX Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountant580310001
    COHEN, Elsie
    34 Oak Lodge Close
    HA7 4QB Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    34 Oak Lodge Close
    HA7 4QB Stanmore
    Middlesex
    BritishLadies Underwear Manufacturer24180670001
    COHEN, Morris
    34 Oak Lodge Close
    HA7 4QB Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    34 Oak Lodge Close
    HA7 4QB Stanmore
    Middlesex
    BritishLadies Underwear Manufacturer24180660001
    COHEN, Stanley Michael
    Kingswood House
    15 Linksway
    Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Kingswood House
    15 Linksway
    Northwood
    Middlesex
    BritishLadies Underwear Manufacturer1752100002
    COURTS, Sarah Susan
    Brockenhirst 2 Brockley Hill
    HA7 4LS Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    Brockenhirst 2 Brockley Hill
    HA7 4LS Stanmore
    Middlesex
    BritishDesigner23866720002
    DAVIES, Tim Morgan
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    Administrateur
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    United KingdomBritishRetail Director197113400001
    FABIAN, Andrew Mark
    139 Woodwarde Road
    SE22 8UP London
    Administrateur
    139 Woodwarde Road
    SE22 8UP London
    United KingdomBritishAccountant61022990001
    FINCH, Russell
    9 Park Place
    W5 5NQ London
    Administrateur
    9 Park Place
    W5 5NQ London
    BritishAccountant70159860001
    FINLAY, David Michael Gordon
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    Administrateur
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    BritishChartered Accountant68232410001
    GARBETT-DAVIES, John Nigel
    21 Stonechat Close
    Rest Bay
    CF36 3QF Porthcawl
    Glam
    Administrateur
    21 Stonechat Close
    Rest Bay
    CF36 3QF Porthcawl
    Glam
    BritishProduction Executive24149340001
    GERETY, James Anthony
    22 Leadale Avenue
    Chingford
    E4 8AT London
    Administrateur
    22 Leadale Avenue
    Chingford
    E4 8AT London
    EnglandBritishDirector35957840001
    GILBERT, Arthur Sheldon
    High Windows 6 Alderbrook
    Cyncoed
    CF2 6QD Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    High Windows 6 Alderbrook
    Cyncoed
    CF2 6QD Cardiff
    South Glamorgan
    BritishConsultant24180730001
    JOHNSON, Ian Paul
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    Administrateur
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    United KingdomBritishFinance Director76187110001
    KEMPSTER, Jonathan
    144 Finchampstead Road
    RG41 2NU Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    144 Finchampstead Road
    RG41 2NU Wokingham
    Berkshire
    BritishAccountant73764250001
    LONG, Alan
    18 Cae Garw
    CF4 9EX Thornhill
    Cardiff
    Administrateur
    18 Cae Garw
    CF4 9EX Thornhill
    Cardiff
    BritishCommercial Executive24180740002
    MAWER, Lorraine Olivia
    The Cedars
    Little Billington
    LU7 9BS Bedfordshire
    Administrateur
    The Cedars
    Little Billington
    LU7 9BS Bedfordshire
    United KingdomBritishMarketing Director29819500001
    MORRIS, Sarah
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    Administrateur
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    EnglandBritishDirector174804590001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    William Baird Limited
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    06 avr. 2016
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies For England & Wales
    Numéro d'enregistrementSc021118
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 19 août 1994
    Livré le 31 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a units 1 to 12 and 20 to 24 chesham industrial estate bury lancashire t/no.SM340341 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 19 août 1994
    Livré le 31 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 1 cyfartha industrial estate merthyr tydfil mid glam and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 août 1994
    Livré le 25 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1. f/h land unit 19 ynyscedwyn industrial estate tongwynlais brecknock powys t/no.WA670042. 2. f/h land 2 & 3 st davids industrial estate pengam islwyn gwent t/no.WA353710. 3. f/h land & buildings west side of pengam road aberbargoed islwyn gwent. T/no.WA180255. 4. f/h land, factory premises church street pontadawe lliw valley west glamorgan.t/no.WA226139.5.f/h land & buildings north west side of quarr road pontardawe lliw valley west glam. T/no.WA390005. 6. f/h land north of purcell avenue port talbot west glam.t/no.WA183881. 7.F/h land north west side of purcell avenue aberavon port talbot west glamorgan t/no.WA109757. 8. f/h north west side of purcell avenue port talbot west glamorgan t/no.WA132115. 9.F/h land & buildings north side of A48 at pyle ogwr mid glam t/no.WA398879. And the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 août 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 juin 1993
    Livré le 02 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 goat mill road merthyr tydfil mid glamorgan.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 02 juil. 1993Enregistrement d'une charge
    • 18 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 juin 1993
    Livré le 02 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H unit 2 cyfartha industrial estate merthyr tydfil mid glamorgan.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 02 juil. 1993Enregistrement d'une charge
    • 18 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge and set off
    Créé le 29 juin 1993
    Livré le 02 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of account no.011675310100 With the bank.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 02 juil. 1993Enregistrement d'une charge
    • 22 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Letter of charge and set off
    Créé le 28 juin 1993
    Livré le 02 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to account no.011675310000 With the bank.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 02 juil. 1993Enregistrement d'une charge
    • 22 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 15 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 18 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 janv. 1987
    Livré le 12 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Factory premises at church street pontardawe lliw valley west glamorgan t/no wa 226139 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 05 janv. 1987
    Livré le 12 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north west side of purcell avenue port talbot afon west glamorgan t/no wa 132115 and/or the proceeds of the sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 05 janv. 1987
    Livré le 12 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north west side of purcell avenue aberavon port talbot west glamorgan t/no wa 109757 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 05 janv. 1987
    Livré le 12 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the north of purcell avenue, port talbot, west glamorgan, t/no wa 183881 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 26 nov. 1986
    Livré le 13 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding the 50% share of S.M.cohen in the proceeds of sale of the mortgaged property under the terms of the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a all that plot of land comprising 1.29 acres or thereabouts together with all buildings and structures erected thereon and for the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 05 févr. 1985
    Livré le 05 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the south side of salford street, bury, greater manchester, tn gm 340341 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 09 nov. 1984
    Livré le 20 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The leasehold property known as unit a weldon industrial estate corby northamptonshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 09 mai 1984
    Livré le 30 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the west side of pengam road, aberbargoed, gwent title no na 180255 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 mai 1984Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0