WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHEWAY HAMPSHIRE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00516469
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL)LLP
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ATLAS (HAMPSHIRE) LIMITED02 déc. 199302 déc. 1993
    WRIGHT RAIN LIMITED26 févr. 195326 févr. 1953

    Quels sont les derniers comptes de WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 08 sept. 2010

    LRESEX

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Changement d'adresse du siège social de Begbies Traynor (Central) Llp 2 Collingwood Street Newcastle upon Tyne NE1 1JF le 07 sept. 2010

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5DR le 07 sept. 2010

    2 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    13 pagesAA

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    legacy

    1 pages287

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    15 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    18 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    19 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages190

    Qui sont les dirigeants de WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SOHAL, Balkar
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    5 North Park
    NG18 4PA Mansfield
    Nottinghamshire
    British122186580001
    LILLY, Kevin Lucius
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Administrateur
    13515 Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmericanDirector110636870001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Administrateur
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmericanDirector61807850002
    REILLY, Michael Andrew
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    Administrateur
    2007 Channelstone Way
    NC 28104 Matthews
    Nc 28104
    Usa
    United StatesAmericanCorporate Controller Chief Acc103500870001
    M.R. SERVICES LIMITED
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    Secrétaire
    C/O Vokes-Air Limited
    Farrington Road
    BB11 5SY Burnley
    Lancashire
    55567600012
    MR SERVICES LIMITED
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Suite 2, Hitching Court, Blacklands Way
    Abingdon Business Park
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    55567600003
    WHEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Suite Two Hitching Court
    Blacklands Way Abingdon Business Par
    OX14 1RG Abingdon
    Oxfordshire
    39955810002
    BOSWELL, Brian Peter
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Garden Cottage Hawford House
    Hawford
    WR3 7SQ Worcester
    Worcestershire
    BritishDirector52804120001
    BRICKER, Ross Benjamin
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Administrateur
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    CanadianAttorney105172080001
    COLE, Ian Robert
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    Administrateur
    4 Knarsdale Close
    Lakeside
    DY5 3RF Brierley Hill
    West Midlands
    BritishAccountant42980510001
    COOK, Norman Joseph
    69 Northbourne Avenue
    BH10 6DQ Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    69 Northbourne Avenue
    BH10 6DQ Bournemouth
    Dorset
    BritishDirector29686540001
    COTTON, Richard John
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    Administrateur
    148 Myton Road
    CV34 6PR Warwick
    EnglandBritishCompany Director45397090001
    DAMEN, Michael John
    Chartmead 360 Vale Road
    Ash Vale
    GU12 5LW Aldershot
    Hampshire
    Administrateur
    Chartmead 360 Vale Road
    Ash Vale
    GU12 5LW Aldershot
    Hampshire
    BritishDirector21170030001
    DETHERIDGE, Ian Martin
    81 Dalkeith Court
    Dudsbury Avenue
    BH22 8DY Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    81 Dalkeith Court
    Dudsbury Avenue
    BH22 8DY Ferndown
    Dorset
    BritishDirector48986470001
    DOHERTY, James Patrick
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    Administrateur
    950 S E 82nd Street Road
    Ocala
    Florida 34480
    IrishCompany President105328280001
    FITCHFORD, Andrew Michael John
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old House
    The Green
    B94 5AJ Tanworth In Arden
    Warwickshire
    BritishFinancial Controller99141670001
    GOPSILL, Michael Clement
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    Wood Cottage
    Norton Road Iverley
    Stourbridge
    West Midlands
    BritishCompany Director32481900001
    HAZLEHURST, Ian James
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Malvern Park Farm
    Widney Manor Road
    B91 3JG Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Engineer43476760001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Wendy House 3 Elf Meadow
    Poulton
    GL7 5HQ Cirencester
    Gloucestershire
    BritishDirector33223550001
    JONES, Alan Martin
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    Administrateur
    5 Firsway
    Wightwick
    WV6 8BJ Wolverhampton
    West Midlands
    BritishDirector47891670001
    KEARNEY, Christopher James
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    Administrateur
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    AmericanDirector85114770001
    LADENBERGER, Daniel Timothy
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    Administrateur
    24 Portland Place
    Saint Louis
    Missouri 63108
    Usa
    AmericanPresident Spx Air Filtration110032170001
    MCGOWAN, John Peter
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    BritishDirector62509010002
    MUNDELL, James Joseph
    Woodcote Barn
    B61 9EE Dodford
    Worcestershire
    Administrateur
    Woodcote Barn
    B61 9EE Dodford
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector13970540001
    WALKER, Craig Allen
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    Administrateur
    Bruhnstrasse 2a
    FOREIGN 40225 Dusseldorf
    Germany
    UsaAccountant109340980001
    WINOWIECKI, Ronald Lee
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    Administrateur
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    AmericanDirector95572300001

    WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Cross guarantee and debenture
    Créé le 04 avr. 2003
    Livré le 09 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transactions
    • 09 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 déc. 1992
    Livré le 07 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries (as defined) under the financing agreement dated 22ND december 1992 and/or the security documents (as defined) or any of them
    Brèves mentions
    See doc ref M76 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank Plcas "Security Trustee" for the Beneficiaries (Asdefined)
    Transactions
    • 07 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 nov. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 29 juin 1988
    Livré le 13 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 13 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture.
    Créé le 11 févr. 1987
    Livré le 19 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to barclay inust international limited as trustee for the lenders as defined under the terms of the facility letter of even dated and the guarantee & debenture
    Brèves mentions
    Floating charge over all the undertaking property, assets and rights whatsoever present and/or future of the company.
    Personnes ayant droit
    • Cin Industrial Investment Limited.
    • Barclay Trust International Limitedas Trustee for Schroder UK Venture Fund And
    Transactions
    • 19 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 11 févr. 1987
    Livré le 18 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Harwood road littlehampton aram west sussex t/n wsx 74999 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 11 févr. 1987
    Livré le 18 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Crowe arch lane ringwood new forest hampshire t/n hp 73054. and/or proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 11 févr. 1987
    Livré le 18 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property known as all that land lying on the east side of crowe arch lane ringwood hampshire and/or proceeds of salethereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 11 févr. 1987
    Livré le 18 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 1987Enregistrement d'une charge

    WHEWAY HAMPSHIRE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 sept. 2010Commencement of winding up
    21 mai 2011Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter Andrew Blair
    Regency House 21 The Ropewalk
    NG1 5DU Nottingham
    Nottinghamshire
    practitioner
    Regency House 21 The Ropewalk
    NG1 5DU Nottingham
    Nottinghamshire
    Andrew D Haslam
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    practitioner
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0