AB OLD CO LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | AB OLD CO LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00815338 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AB OLD CO LIMITED ?
Adresse du siège social | Premier House Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Hertfordshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AB OLD CO LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour AB OLD CO LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew John Mcdonald en tant que directeur le 07 janv. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Restauration par ordonnance du tribunal | 3 pages | AC92 | ||||||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Nomination de Mr Duncan Neil Leggett en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Emmett Mcevoy en tant que directeur le 12 janv. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Emmett Mcevoy le 05 juil. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Emmett Mcevoy en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Antony Smith en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed avana bakeries LIMITED\certificate issued on 05/12/11 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mr Andrew Mcdonald en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Suzanne Wise en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Avis de suppression de la restriction sur les statuts de la société | 2 pages | CC02 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 34 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de AB OLD CO LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secrétaire | Premier House Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
LEGGETT, Duncan Neil | Administrateur | Premier House Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 194179970001 | ||||
WILBRAHAM, Simon Nicholas | Administrateur | Premier House Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 125719290002 | ||||
BURTON, Denise Patricia | Secrétaire | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
HARTREY, Patrick Mark | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
HINES, Christine Anne | Secrétaire | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
MANSON, Keith Mackenzie | Secrétaire | 47 Dorchester Avenue Penylan CF3 7BS Cardiff South Glamorgan | British | 150094600001 | ||||||
MILLER, Roger Keith | Secrétaire | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | Company Secretary | 120645920001 | |||||
WATERS, Paul Christopher | Secrétaire | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secrétaire | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
WOODMORE, Michael Brian | Secrétaire | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
ALLNER, Andrew James | Administrateur | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | Finance Director Chartered Acc | 73003300001 | |||||
ALSTEAD, Robert Geoffrey | Administrateur | 5 Knowbury Avenue CF64 5RX Penarth Vale Of Glamorgan | Wales | British | Director | 73645360002 | ||||
BURGIN, Stuart | Administrateur | 31 The Crescent Worsley Road M28 2WY Manchester Greater Manchester | British | Director | 90195130001 | |||||
BURN, Lance Andrew | Administrateur | Potters Wood Barn Park Farm Botany Bay DE12 8DY Grangewood Derbyshire | British | Managing Director | 105041990001 | |||||
CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Administrateur | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 98818450001 | ||||
CLEE, Peter Morton | Administrateur | Marle Piece Great Doward HR9 6DZ Ross On Wye Herefordshire | United Kingdom | British | Company Director | 36258430001 | ||||
CROSSLEY, Nigel | Administrateur | Tempsford 34 Grove Road HP9 1PE Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | Financial Director | 145901880001 | ||||
DAVIES, Philip Anthony | Administrateur | Lletty Henry Cwrt Henri SA32 8SA Dryslwyn Carmarthen | British | Director | 72470800001 | |||||
DUNCAN, Ian Alexander | Administrateur | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | Company Director | 27300002 | ||||
HORWOOD, Lionel | Administrateur | 61 Heol Llanishen Fach Rhiwbina CF4 6LB Cardiff | British | Director | 35341030001 | |||||
KELLY, Timothy Geoffrey | Administrateur | The Mansion House Abbotts Inn SP11 7AU Andover Hampshire | England | British | Director | 92817300001 | ||||
LAWSON, Robert | Administrateur | 36 Exeter Road NW2 4SB London | England | British | Director | 99991140001 | ||||
MANSON, Keith Mackenzie | Administrateur | 47 Dorchester Avenue Penylan CF3 7BS Cardiff South Glamorgan | United Kingdom | British | Director | 150094600001 | ||||
MARCHANT, Richard Norman | Administrateur | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | Company Secretary/Director | 26880001 | |||||
MCDONALD, Andrew John | Administrateur | Premier House Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Hertfordshire | England | British | General Counsel & Company Secretary | 164670820001 | ||||
MCEVOY, Emmett | Administrateur | Premier House Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Hertfordshire | United Kingdom | Irish | Director | 168590540001 | ||||
MCMAHON, Ian Reid | Administrateur | The Gate House Burfield Road SL4 2LH Old Windsor Berkshire | British | Chief Executive | 84644240002 | |||||
MITCHELL, John Wemyss Houston | Administrateur | 175 Cyncoed Road CF2 6AH Cardiff South Glamorgan | British | Company Director | 18042300001 | |||||
MURPHY, Thomas Jerome Peter | Administrateur | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | General Counsel | 76945730001 | |||||
OAKLEY, Christopher Richard | Administrateur | 26 Long Park Chesham Bois HP6 5LA Amersham Buckinghamshire | England | British | Director | 124625030001 | ||||
PANTER, Alan James, Mr. | Administrateur | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | Chartered Accountant | 114414690002 | |||||
PEELER, Andrew Michael | Administrateur | Premier House Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Controller | 87359710001 | ||||
RUDDICK, Ian William | Administrateur | 32 Woodend Drive SL5 9BG Ascot Berkshire | United Kingdom | British | Director | 98350001 | ||||
SANDERS, Anthony John | Administrateur | 2 Wood Crescent Rogerstone NP1 0AL Newport Gwent | British | Company Director | 18042310001 |
AB OLD CO LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 26 juil. 2004 Livré le 06 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Rogerstone factory wern industrial estate newport newport gwent f/h t/n's WA717369 WA345955, pendyris street cardiff f/h t/n WA716794. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Créé le 11 sept. 2000 Livré le 23 sept. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0