AB OLD CO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAB OLD CO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00815338
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AB OLD CO LIMITED ?

    • Fabrication de pain; fabrication de pâtisseries fraîches et de gâteaux (10710) / Industries manufacturières

    Où se situe AB OLD CO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AB OLD CO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AVANA BAKERIES LIMITED11 août 196411 août 1964

    Quels sont les derniers comptes de AB OLD CO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour AB OLD CO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Andrew John Mcdonald en tant que directeur le 07 janv. 2021

    1 pagesTM01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Nomination de Mr Duncan Neil Leggett en tant qu'administrateur le 12 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Emmett Mcevoy en tant que directeur le 12 janv. 2015

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 sept. 2013

    État du capital au 16 sept. 2013

    • Capital: GBP 7,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Emmett Mcevoy le 05 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Nomination de Emmett Mcevoy en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Antony Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed avana bakeries LIMITED\certificate issued on 05/12/11
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name05 déc. 2011

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name05 déc. 2011

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Nomination de Mr Andrew Mcdonald en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Suzanne Wise en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Avis de suppression de la restriction sur les statuts de la société

    2 pagesCC02

    Résolutions

    Resolutions
    34 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de AB OLD CO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    LEGGETT, Duncan Neil
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector194179970001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Secrétaire
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secrétaire
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MANSON, Keith Mackenzie
    47 Dorchester Avenue
    Penylan
    CF3 7BS Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire
    47 Dorchester Avenue
    Penylan
    CF3 7BS Cardiff
    South Glamorgan
    British150094600001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Administrateur
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    BritishFinance Director Chartered Acc73003300001
    ALSTEAD, Robert Geoffrey
    5 Knowbury Avenue
    CF64 5RX Penarth
    Vale Of Glamorgan
    Administrateur
    5 Knowbury Avenue
    CF64 5RX Penarth
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritishDirector73645360002
    BURGIN, Stuart
    31 The Crescent
    Worsley Road
    M28 2WY Manchester
    Greater Manchester
    Administrateur
    31 The Crescent
    Worsley Road
    M28 2WY Manchester
    Greater Manchester
    BritishDirector90195130001
    BURN, Lance Andrew
    Potters Wood Barn Park Farm
    Botany Bay
    DE12 8DY Grangewood
    Derbyshire
    Administrateur
    Potters Wood Barn Park Farm
    Botany Bay
    DE12 8DY Grangewood
    Derbyshire
    BritishManaging Director105041990001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Administrateur
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant98818450001
    CLEE, Peter Morton
    Marle Piece
    Great Doward
    HR9 6DZ Ross On Wye
    Herefordshire
    Administrateur
    Marle Piece
    Great Doward
    HR9 6DZ Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director36258430001
    CROSSLEY, Nigel
    Tempsford
    34 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Tempsford
    34 Grove Road
    HP9 1PE Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinancial Director145901880001
    DAVIES, Philip Anthony
    Lletty Henry
    Cwrt Henri
    SA32 8SA Dryslwyn
    Carmarthen
    Administrateur
    Lletty Henry
    Cwrt Henri
    SA32 8SA Dryslwyn
    Carmarthen
    BritishDirector72470800001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Administrateur
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritishCompany Director27300002
    HORWOOD, Lionel
    61 Heol Llanishen Fach
    Rhiwbina
    CF4 6LB Cardiff
    Administrateur
    61 Heol Llanishen Fach
    Rhiwbina
    CF4 6LB Cardiff
    BritishDirector35341030001
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    Administrateur
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritishDirector92817300001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Administrateur
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritishDirector99991140001
    MANSON, Keith Mackenzie
    47 Dorchester Avenue
    Penylan
    CF3 7BS Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    47 Dorchester Avenue
    Penylan
    CF3 7BS Cardiff
    South Glamorgan
    United KingdomBritishDirector150094600001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Secretary/Director26880001
    MCDONALD, Andrew John
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishGeneral Counsel & Company Secretary164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrishDirector168590540001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    BritishChief Executive84644240002
    MITCHELL, John Wemyss Houston
    175 Cyncoed Road
    CF2 6AH Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur
    175 Cyncoed Road
    CF2 6AH Cardiff
    South Glamorgan
    BritishCompany Director18042300001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Counsel76945730001
    OAKLEY, Christopher Richard
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector124625030001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Administrateur
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    BritishChartered Accountant114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House Centrium Business
    Park Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Controller87359710001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector98350001
    SANDERS, Anthony John
    2 Wood Crescent
    Rogerstone
    NP1 0AL Newport
    Gwent
    Administrateur
    2 Wood Crescent
    Rogerstone
    NP1 0AL Newport
    Gwent
    BritishCompany Director18042310001

    AB OLD CO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 juil. 2004
    Livré le 06 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rogerstone factory wern industrial estate newport newport gwent f/h t/n's WA717369 WA345955, pendyris street cardiff f/h t/n WA716794. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 06 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Créé le 11 sept. 2000
    Livré le 23 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust of New York(The "Security Agent")
    Transactions
    • 23 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0