CHARNWOOD FOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHARNWOOD FOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01205129
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHARNWOOD FOODS LIMITED ?

    • Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10890) / Industries manufacturières

    Où se situe CHARNWOOD FOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHARNWOOD FOODS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BUTTERKUP FOODS LIMITED28 août 198628 août 1986
    SAMAC FOOD SERVICES LIMITED26 mars 197526 mars 1975

    Quels sont les derniers comptes de CHARNWOOD FOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour CHARNWOOD FOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 sept. 2012

    État du capital au 25 sept. 2012

    • Capital: GBP 1,500,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Nomination de Emmett Mcevoy en tant qu'administrateur le 20 avr. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Antony David Smith en tant que directeur le 20 avr. 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Andrew Mcdonald en tant qu'administrateur le 15 nov. 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Suzanne Elizabeth Wise en tant que directeur le 15 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Avis de suppression de la restriction sur les statuts de la société

    2 pagesCC02

    Résolutions

    Resolutions
    34 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Mr Antony David Smith en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Peeler en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Michael Peeler le 05 juin 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Suzanne Elizabeth Wise le 05 juin 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Simon Nicholas Wilbraham le 05 juin 2011

    1 pagesCH03

    Nomination de Mr Simon Nicholas Wilbraham en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de CHARNWOOD FOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Administrateur
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Secrétaire
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secrétaire
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Administrateur
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Administrateur
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Administrateur
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Administrateur
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    GRANT, Brian John
    The Light House
    North Street Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    The Light House
    North Street Winkfield
    SL4 4SY Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish64875090001
    HARGREAVES, Stephen John
    Stable House
    Smeeton Road
    LE8 0QT Saddington
    Leicestershire
    Administrateur
    Stable House
    Smeeton Road
    LE8 0QT Saddington
    Leicestershire
    Great BritainBritish99437380001
    HODSON, Mark Anthony
    Orchard Barn
    Bulby
    PE10 0RU Bourne
    Lincolnshire
    Administrateur
    Orchard Barn
    Bulby
    PE10 0RU Bourne
    Lincolnshire
    EnglandBritish142364940001
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    Administrateur
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritish92817300001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Administrateur
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    British84644240002
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    OAKLEY, Christopher Richard
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124625030001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Administrateur
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    PICKERING, Alistair Neil
    13 Upper Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7UW Bristol
    Administrateur
    13 Upper Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7UW Bristol
    United KingdomBritish83785410002
    QUICK, Nigel Robert
    Autumn Cottage
    8 Gladstone Street
    LE8 0HL Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    Administrateur
    Autumn Cottage
    8 Gladstone Street
    LE8 0HL Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    British36629900001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish98350001
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Administrateur
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish42065200002
    SIMMONS, Alex Thomas
    39 Pedmore Lane
    Pedmore
    DY9 0SY Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    39 Pedmore Lane
    Pedmore
    DY9 0SY Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish105865430001
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Administrateur
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish147725160001
    SWEENEY, Brendan John
    Long Owl Barn
    Coed Y Paen
    NP4 0TB Pontypool
    Gwent
    Administrateur
    Long Owl Barn
    Coed Y Paen
    NP4 0TB Pontypool
    Gwent
    British Irish79007350001
    WHITING, Timothy James
    57 Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    57 Beauchamp Avenue
    CV32 5TB Leamington Spa
    Warwickshire
    British44028500002
    WIGNALL, Howard Ernest Edwin
    62 Garland
    Rothley
    LE7 7RG Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    62 Garland
    Rothley
    LE7 7RG Leicester
    Leicestershire
    British32234150001

    CHARNWOOD FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 juil. 2004
    Livré le 06 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Loweth woods magna road south wigston leicester f/h, de montford (garage) magna road south wigston leicester f/H. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 06 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Créé le 11 sept. 2000
    Livré le 23 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    Transactions
    • 23 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 juil. 1981
    Livré le 23 juil. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital & all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 juil. 1981Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds without instrument
    Créé le 20 sept. 1979
    Livré le 24 sept. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Lease of premises at carpenters place, london SW4.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1979Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds without instrument
    Créé le 20 sept. 1979
    Livré le 24 sept. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    L/H premises known as unit A3, park hall road trading estate, london SE21.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1979Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0