CHARNWOOD FOODS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CHARNWOOD FOODS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01205129 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CHARNWOOD FOODS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CHARNWOOD FOODS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour CHARNWOOD FOODS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Emmett Mcevoy en tant qu'administrateur le 20 avr. 2012 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Antony David Smith en tant que directeur le 20 avr. 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Andrew Mcdonald en tant qu'administrateur le 15 nov. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Suzanne Elizabeth Wise en tant que directeur le 15 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Avis de suppression de la restriction sur les statuts de la société | 2 pages | CC02 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 34 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Antony David Smith en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Peeler en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 05 juin 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Michael Peeler le 05 juin 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Suzanne Elizabeth Wise le 05 juin 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Simon Nicholas Wilbraham le 05 juin 2011 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Simon Nicholas Wilbraham en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CHARNWOOD FOODS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secrétaire | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
| MCDONALD, Andrew John | Administrateur | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | England | British | 164670820001 | |||||
| MCEVOY, Emmett | Administrateur | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 168590540001 | |||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Administrateur | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | England | British | 125719290002 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Secrétaire | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| HARTREY, Patrick Mark | Secrétaire | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
| HINES, Christine Anne | Secrétaire | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Secrétaire | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
| WATERS, Paul Christopher | Secrétaire | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secrétaire | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
| WOODMORE, Michael Brian | Secrétaire | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
| ALLNER, Andrew James | Administrateur | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | 73003300001 | ||||||
| CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Administrateur | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 98818450001 | |||||
| CROSSLEY, Nigel | Administrateur | HP9 | England | British | 145901880001 | |||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Administrateur | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||
| GRANT, Brian John | Administrateur | The Light House North Street Winkfield SL4 4SY Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 64875090001 | |||||
| HARGREAVES, Stephen John | Administrateur | Stable House Smeeton Road LE8 0QT Saddington Leicestershire | Great Britain | British | 99437380001 | |||||
| HODSON, Mark Anthony | Administrateur | Orchard Barn Bulby PE10 0RU Bourne Lincolnshire | England | British | 142364940001 | |||||
| KELLY, Timothy Geoffrey | Administrateur | The Mansion House Abbotts Inn SP11 7AU Andover Hampshire | England | British | 92817300001 | |||||
| LAWSON, Robert | Administrateur | 36 Exeter Road NW2 4SB London | England | British | 99991140001 | |||||
| MARCHANT, Richard Norman | Administrateur | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MCMAHON, Ian Reid | Administrateur | The Gate House Burfield Road SL4 2LH Old Windsor Berkshire | British | 84644240002 | ||||||
| MURPHY, Thomas Jerome Peter | Administrateur | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 76945730001 | ||||||
| OAKLEY, Christopher Richard | Administrateur | 26 Long Park Chesham Bois HP6 5LA Amersham Buckinghamshire | England | British | 124625030001 | |||||
| PANTER, Alan James, Mr. | Administrateur | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | 114414690002 | ||||||
| PEELER, Andrew Michael | Administrateur | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 87359710001 | |||||
| PICKERING, Alistair Neil | Administrateur | 13 Upper Cranbrook Road Redland BS6 7UW Bristol | United Kingdom | British | 83785410002 | |||||
| QUICK, Nigel Robert | Administrateur | Autumn Cottage 8 Gladstone Street LE8 0HL Kibworth Beauchamp Leicestershire | British | 36629900001 | ||||||
| RUDDICK, Ian William | Administrateur | 32 Woodend Drive SL5 9BG Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 98350001 | |||||
| SCHURCH, Michael John | Administrateur | 1 Aldersey Road GU1 2ER Guildford Surrey | United Kingdom | British | 42065200002 | |||||
| SIMMONS, Alex Thomas | Administrateur | 39 Pedmore Lane Pedmore DY9 0SY Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | 105865430001 | |||||
| SMITH, Antony David | Administrateur | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | United Kingdom | British | 147725160001 | |||||
| SWEENEY, Brendan John | Administrateur | Long Owl Barn Coed Y Paen NP4 0TB Pontypool Gwent | British Irish | 79007350001 | ||||||
| WHITING, Timothy James | Administrateur | 57 Beauchamp Avenue CV32 5TB Leamington Spa Warwickshire | British | 44028500002 | ||||||
| WIGNALL, Howard Ernest Edwin | Administrateur | 62 Garland Rothley LE7 7RG Leicester Leicestershire | British | 32234150001 |
CHARNWOOD FOODS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 26 juil. 2004 Livré le 06 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Loweth woods magna road south wigston leicester f/h, de montford (garage) magna road south wigston leicester f/H. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Créé le 11 sept. 2000 Livré le 23 sept. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 17 juil. 1981 Livré le 23 juil. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital & all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit of deeds without instrument | Créé le 20 sept. 1979 Livré le 24 sept. 1979 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Lease of premises at carpenters place, london SW4. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deposit of deeds without instrument | Créé le 20 sept. 1979 Livré le 24 sept. 1979 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions L/H premises known as unit A3, park hall road trading estate, london SE21. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0