YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED

YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéYORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02066471
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UPPERMINOR LIMITED22 oct. 198622 oct. 1986

    Quels sont les derniers comptes de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 20 juin 2018

    6 pagesLIQ03

    Modification des détails de Tilney Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 janv. 2017

    2 pagesPSC05

    Modification des détails de Tilney Bestinvest Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 déc. 2016

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England à 15 Canada Square London E14 5GL le 18 juil. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 juin 2017

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF England à 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ

    1 pagesAD02

    Déclaration de confirmation établie le 06 avr. 2017 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Cessation de la nomination de John Robert Porteous en tant que directeur le 28 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Wadham St.John Downing en tant qu'administrateur le 21 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England à C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL le 02 nov. 2016

    1 pagesAD01

    Nomination de Mrs Rehana Hasan en tant que secrétaire le 31 oct. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jacqueline Anne Gregory en tant que secrétaire le 31 oct. 2016

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Robert Alan Devey en tant que directeur le 29 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Vernon Wright en tant que directeur le 30 juin 2016

    1 pagesTM01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL

    1 pagesAD04

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Towry, 17th Floor, 6 New Street Square London EC4A 3BF

    1 pagesAD03

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mars 2016

    État du capital au 31 mars 2016

    • Capital: GBP 5,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Jacqueline Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England à C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL le 31 mars 2016

    1 pagesAD01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2016 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Qui sont les dirigeants de YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HASAN, Rehana
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    217676460001
    DOWNING, Wadham St. John
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    England
    Administrateur
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    England
    England
    EnglandBritish203301710001
    BELLAMY, Martin William
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Secrétaire
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    173986860001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Secrétaire
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    197500790001
    HERON, Hugh
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    Secrétaire
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    British26428410003
    JOHNSTON, Carol Ann
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    Secrétaire
    9i Calles Las Palmeras
    Urb Vista Laguna
    11312 Torreguadiaro
    Cadiz
    Spain
    British52538020003
    NICHOLS, Sarah
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Lisbon Square
    LS1 4LY Leeds
    8
    West Yorkshire
    United Kingdom
    British157100100001
    PEACOCK, Natasha Valerie
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    Secrétaire
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    British129803720001
    BRADSHAW, Phillip Gordon
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    Springfield Farm
    Hardwick Road East Hardwick
    WF8 3DL Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish26428400002
    BUSSEY, Michael Adrian
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish52554700003
    CHAPMAN, Andrew
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ask House 88 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9AN Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish39777190002
    COLEMAN, Lynn Rose
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Administrateur
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomBritish149721950001
    COONEY, Dominic Francis
    The Spinney
    WF2 6JN Wakefield
    15
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    The Spinney
    WF2 6JN Wakefield
    15
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish138563720001
    CRESSWELL-TURNER, Miles Marius
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish135272850001
    DEVEY, Robert Alan
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish146956760001
    FLOWER, Gordon Mark
    Sovereign Fold
    HG5 0WJ Knaresborough
    4
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Sovereign Fold
    HG5 0WJ Knaresborough
    4
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish133025980001
    FOX, Chay Munro
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Administrateur
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomBritish172112550001
    HAINES, Stephen Paul
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Administrateur
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    EnglandBritish185462290001
    HERON, Hugh
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    114 Carleton Road
    WF8 3NQ Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritish26428410003
    HOGG, Andrew
    1 Park House Mill
    Renton Close Bishop Monkton
    HG3 1BW Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    1 Park House Mill
    Renton Close Bishop Monkton
    HG3 1BW Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish63356910007
    JACOBS, Andrew Stephen
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Administrateur
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomBritish183659460001
    JOHNSTON, Carol Ann
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    Administrateur
    Brindley House Valley Road
    Killamarsh
    S21 1JB Sheffield
    British52538020002
    JONES, Gaius Trefor Griffith
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Administrateur
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    EnglandBritish57884740001
    JONES, Peter Francis
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    15 Wigton Park Close
    LS17 8UH Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish33965180002
    MIDGLEY, Steven Richard
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Administrateur
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    EnglandBritish186658380001
    MULLORD, Kathleen Francis
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    Ropergate House
    43 Ropergate
    WF8 1JY Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomSouth African160087800001
    NICHOLS, Sarah Elizabeth
    1 Home Farm Square
    Birstwith
    HG3 2WA Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    1 Home Farm Square
    Birstwith
    HG3 2WA Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish93464600001
    PEACOCK, Natasha Valerie
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    Administrateur
    Pear Tree Drive
    SK15 2PY Stalybridge
    7
    Cheshire
    EnglandBritish129803720001
    POLIN, Jonathan Charles
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Administrateur
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    ScotlandBritish97840060003
    PORTEOUS, John Robert
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o Rehana Hasan, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish166212270001
    SAWYER, Gareth Matthew
    5 Chelmsford Road
    HG1 5NA Harrogate
    Administrateur
    5 Chelmsford Road
    HG1 5NA Harrogate
    United KingdomBritish46468670003
    SUMMERELL, Paul
    11 Cricketers Fold
    Shadwell
    LS17 8WE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    11 Cricketers Fold
    Shadwell
    LS17 8WE Leeds
    West Yorkshire
    British96162090001
    TAGLIABUE, Alfio
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    Administrateur
    Queen Victoria Street
    EC4N 4TR London
    60
    England
    United KingdomItalian76352220004
    WRIGHT, Paul Vernon
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    Administrateur
    c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary
    Western Road
    RG12 1TL Bracknell
    Towry House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish137936580001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    17th Floor
    6 New Street Square, New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    Towry Group
    England
    England
    06 avr. 2016
    17th Floor
    6 New Street Square, New Fetter Lane
    EC4A 3BF London
    Towry Group
    England
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04126418
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment of debts by way of security
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 19 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All future rights title and interest and benefits in the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over cash deposit
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 16 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit and all the present and future rights titles and benefit of the company in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of debts by way of security
    Créé le 29 sept. 2004
    Livré le 15 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or yorkshire investment group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First priority assignment all present and future rights,titles and interest in and benefits of the company in the debts,together with the benefit of any and all intermediary contracts or agency agreements.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 oct. 2002
    Livré le 17 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture deed
    Créé le 28 févr. 2001
    Livré le 06 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    YORKSHIRE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 mars 2019Dissolved on
    21 juin 2017Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0