MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED

MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02157370
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED29 févr. 198829 févr. 1988
    BURGINHALL 194 LIMITED26 août 198726 août 1987

    Quels sont les derniers comptes de MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW à 15 Canada Square London E14 5GL le 03 mai 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 avr. 2019

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Comptes de micro-entité établis au 30 avr. 2018

    2 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 avr. 2019 au 31 mars 2019

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Ian Michael Noble en tant que directeur le 06 août 2018

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen James Callaghan le 06 août 2018

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 avr. 2017

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2016

    4 pagesAA

    Nomination de Ian Michael Noble en tant qu'administrateur le 06 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Coll en tant que directeur le 06 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen James Callaghan en tant qu'administrateur le 10 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Meaden en tant que directeur le 10 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juin 2016

    État du capital au 01 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 juin 2015

    État du capital au 29 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2014

    4 pagesAA

    Nomination de David John Meaden en tant qu'administrateur le 22 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Pinsent Masons Secretarial Limited en tant que secrétaire le 22 déc. 2014

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de John Robert Stier en tant que directeur le 22 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Secrétaire
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Secrétaire
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    Secrétaire
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    YOUNG, Victor John
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Willow Bank Willow View Close
    SN16 0BZ Malmesbury
    Wiltshire
    British23808250002
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    CHESTER, Andrew, Dr
    71 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QG Bristol
    Avon
    Administrateur
    71 Downs Park East
    Westbury Park
    BS6 7QG Bristol
    Avon
    British36723830001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    GREENLAND, Martyn Geoffrey
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    British45440250001
    MACHIN, Brian Roy
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    Administrateur
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    British8982230003
    MARKHAM, Richard John
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    Administrateur
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    United KingdomBritish35544120002
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    RUDD, Jeremy George Winterton
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    Administrateur
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    United KingdomBritish74891640002
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    VENN, Jon
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    Administrateur
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    British15778460001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03033447
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 26 sept. 1997
    Livré le 02 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of variation
    Créé le 15 mai 1995
    Livré le 16 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the obligations undertakings and liabilities of the company to the chargee (as defined in a charge dated 21ST october 1988)
    Brèves mentions
    Pursuant to clause 2 if the charge (as amended by the deed of variation) all right title & interest in the local authority agreement & in the settlement agreement but without limitation the benefit of all powers & remedies but excluding all amounts payable thereunder in respect of vat. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed (amending the charge dated 20TH july 1988 and the supplemental charge dated 18TH november 1991)
    Créé le 12 mai 1994
    Livré le 14 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    And amending the charge dated 20TH july 1988 (the "general clc charge") and the supplemental charge dated 18TH november 1991 (the "supplemental charge")
    Brèves mentions
    (I) first fixed charge all clc's right title and interest in each of the deposits (ii) first fixed charge all clc's right title and interest in the digital agreement (iii) first fixed charge all clc's right title and interest in the csl agreement (iv) floating charge all undertaking property assets and rights....... See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 13 mai 1993
    Livré le 21 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the advance (as defined therein) under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the local authority agreement including the benefit of all powers and remedies for enforcing the same but excluding all amounts payable to the company thereunder in respect of V.A.T.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Specific digital security
    Créé le 13 mai 1993
    Livré le 21 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined therein) and/or this deed
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all the machinery equipment and other chattels as listed on the form 395 inclusive of clc gateway and one VT320 terminal and keyboard. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transactions
    • 21 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 23 déc. 1992
    Livré le 05 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and in relation to or in connection with the advance (as defined therein) and other monies due in respect thereof
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge clc's right title and interest in the local authority agreement for full details see form 395 and schedule attached.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over contract
    Créé le 04 nov. 1992
    Livré le 19 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that benefit of an agreement dated 10/4/90 between the company and hartlepool borough council.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Specific digital security
    Créé le 13 oct. 1992
    Livré le 26 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the indemnity as defined therein
    Brèves mentions
    First fixed charge all right title and interest of the company in the equipment as detailed on form 395 see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transactions
    • 26 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 13 oct. 1992
    Livré le 20 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of thw charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the local authority agreement for full details see form 395.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 27 avr. 1992
    Livré le 06 mai 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance (as defined) and/or this charge
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest in the local authority agreement (as defined) ....(please see doc for full details).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 mai 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 23 mars 1992
    Livré le 24 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC in connection with the advance (as defined) and/or this charge.
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge, clc's right, title and interest in the local authority agreement (as defined). (See doc 395 reference M8L for full details).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Specific digital security
    Créé le 25 févr. 1992
    Livré le 09 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the indemnity contained in clause 5 of the clc digital agreement dated 25/7/89
    Brèves mentions
    1 oracle database licence and various items of equipment see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transactions
    • 09 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 17 févr. 1992
    Livré le 22 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the advance (as defined therein) under the terms of the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge clc's right, title and interest in the local authority agreement see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 20 déc. 1991
    Livré le 07 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC in relation to the advance applicable to hereford city council under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in the local authority agreement (please see doc M395 reference M247 for full details).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental charge
    Créé le 18 nov. 1991
    Livré le 29 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of second fixed charge ,clc's right title and interest in each of the deposits ,the digital agreement,the csl agreement. Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 06 sept. 1991
    Livré le 12 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance (as defined)
    Brèves mentions
    All the company's interest in and to the local authority agreement (please see form 395 for details).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 25 juil. 1991
    Livré le 01 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the 'advance' this charge as defined
    Brèves mentions
    Pursuant to clause 2 of the charge clc has as sole absolute and beneficial owner thereof, charged in favour of the bank by way of first fixed charge C.L.c's right title and interest in the local authority agreement. As defined on form 395 M9.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 25 juil. 1991
    Livré le 01 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the "advance" this charge as defined.
    Brèves mentions
    Pursuant to clause 2 of the charge clc has as sole, absolute and beneficial owner thereof, charged in favour of the bank by way of first fixed charge clc's right, title and interest in the local authority agreement (as defined on the form 395 M10).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Specific digital security.
    Créé le 08 mai 1991
    Livré le 28 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined therein) and this charge.
    Brèves mentions
    All right title and interest of the company in the equipment specified on form M395 (see form M395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Digital Equipment Co. Limited
    Transactions
    • 28 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 08 mai 1991
    Livré le 10 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance and all other moneys due in respect thereof under the terms of the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge clc's right title & interest in the local authority. Agreement (for full details see form 395 & schedule detailed).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Specific digital security
    Créé le 16 avr. 1991
    Livré le 27 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement, the digital payment and the clc/digital agreement and this charge.
    Brèves mentions
    (See 395 for details).
    Personnes ayant droit
    • Digital Equipment Co. Limited.
    Transactions
    • 27 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Specific digital security
    Créé le 16 avr. 1991
    Livré le 27 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement, the digital payment and the clc/digital agreement and this charge.
    Brèves mentions
    (See 395 for details).
    Personnes ayant droit
    • Digital Equipment Co. Limited.
    Transactions
    • 27 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 16 avr. 1991
    Livré le 26 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 16 avr. 1991
    Livré le 26 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to or in connection with the advance under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 09 janv. 1991
    Livré le 23 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge clc's right title & interest in the local authority agreement (for full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MVM CENTRAL LAND CHARGES COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 avr. 2019Commencement of winding up
    01 févr. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0