RYSBRIDGE ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRYSBRIDGE ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02178607
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RYSBRIDGE ESTATES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe RYSBRIDGE ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RYSBRIDGE ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PORTRENT LIMITED14 oct. 198714 oct. 1987

    Quels sont les derniers comptes de RYSBRIDGE ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour RYSBRIDGE ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    39 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 avr. 2017

    28 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 avr. 2016

    31 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 avr. 2015

    33 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 avr. 2014

    33 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 179 Great Portland Street London W1W 5LS le 22 avr. 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Cessation de la nomination d'un directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nicolae Christopher Ratiu en tant que directeur le 14 févr. 2013

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr William Robert Starn en tant qu'administrateur le 14 mars 2013

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jagtar Singh en tant que directeur le 08 mai 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Gary Balfour-Lynn en tant que directeur le 31 mars 2012

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 déc. 2011

    État du capital au 13 déc. 2011

    • Capital: GBP 4,400
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2010 au 30 juin 2011

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Blurton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    21 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Francis Blurton le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de RYSBRIDGE ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CITY GROUP PLC
    30 City Road
    EC1Y 2AG London
    Secrétaire
    30 City Road
    EC1Y 2AG London
    35794270004
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Secrétaire
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    KARMEL, Simon Harry
    Elm Tree Road
    NW8 9JP London
    20
    Administrateur
    Elm Tree Road
    NW8 9JP London
    20
    EnglandBritish2014130001
    STARN, William Robert
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Administrateur
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandAmerican154007330001
    LIPSCOMB, Helen
    11 Herbert Road
    N11 2QN London
    Secrétaire
    11 Herbert Road
    N11 2QN London
    British5036040002
    PALMER, Martin Trevor Digby
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    Hill House
    Crook Road Brenchley
    TN12 7BS Tonbridge
    Kent
    British79436600001
    WOOLLEY, Roderic Harry
    Clamara
    62 Kingsclere Road
    RG25 3JB Overton
    Hampshire
    Secrétaire
    Clamara
    62 Kingsclere Road
    RG25 3JB Overton
    Hampshire
    British1017530003
    ARTUS, Alan Norman
    10 Cambridge Road
    SW11 4RS London
    Administrateur
    10 Cambridge Road
    SW11 4RS London
    British72061440002
    AUSTEN, Jonathan Martin
    68 Braxted Park
    SW16 3AU London
    Administrateur
    68 Braxted Park
    SW16 3AU London
    British36694850001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Administrateur
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish53724380001
    BOWES, Graham
    Wavertree
    20 St Peters Road
    TW1 1QX St. Margarets, Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    Wavertree
    20 St Peters Road
    TW1 1QX St. Margarets, Twickenham
    Middlesex
    British37707190003
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Administrateur
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    INGMAN, Philip Michael
    Flat 6 Bridge House
    298 Wandsworth Bridge Road
    SW6 2TT London
    Administrateur
    Flat 6 Bridge House
    298 Wandsworth Bridge Road
    SW6 2TT London
    British54153030001
    MCDONALD, Peter Stuart
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    Administrateur
    4 St Stephens Terrace
    SW8 1DH London
    British77781180001
    PLUMMER, Jeremy James
    Springwell House The Street
    North Warnborough
    RG29 1BD Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Springwell House The Street
    North Warnborough
    RG29 1BD Hook
    Hampshire
    EnglandBritish3994380002
    POPE, Nigel Howard
    3 Rolleston Close
    Petts Wood
    BR5 1AN Orpington
    Kent
    Administrateur
    3 Rolleston Close
    Petts Wood
    BR5 1AN Orpington
    Kent
    British29583660001
    RATIU, Nicolae Christopher
    47 Clifton Hill
    NW8 0QE London
    Administrateur
    47 Clifton Hill
    NW8 0QE London
    United KingdomBritish67475010001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Administrateur
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SHEEHAN, Nicholas John Philip
    Upperfold Hewshott Lane
    GU30 7SU Liphook
    Hampshire
    Administrateur
    Upperfold Hewshott Lane
    GU30 7SU Liphook
    Hampshire
    British39476870001
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    Administrateur
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    SLOAN, Roderick David Gray
    3 The Redwoods
    Bolton Avenue
    SL4 3TA Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    3 The Redwoods
    Bolton Avenue
    SL4 3TA Windsor
    Berkshire
    British9739700002
    STEVENS, Michael
    21 Chestnut Close
    HP6 6EQ Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    21 Chestnut Close
    HP6 6EQ Amersham
    Buckinghamshire
    British60348780001
    TIPPING, Geoffrey Nigel
    The Nursery
    Manningford Abbots
    SN9 5PB Pewsey
    Wiltshire
    Administrateur
    The Nursery
    Manningford Abbots
    SN9 5PB Pewsey
    Wiltshire
    United KingdomBritish80925340001
    WALSH, David George Patrick
    Manor Farm
    Little Cheverell
    SN10 4JP Devizes
    Wiltshire
    Administrateur
    Manor Farm
    Little Cheverell
    SN10 4JP Devizes
    Wiltshire
    British11107290001

    RYSBRIDGE ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 04 juil. 2000
    Livré le 10 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company and any other company named therein to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed charge all right title and interest in each of the assets: real property, bank accounts, insurances, benefit of licenses consents and authorisations. Floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 10 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 avr. 2000
    Livré le 21 avr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All liabilities of the obligors owed or expressed to be owed to the charge (the agent) and to the beneficiaries under or in connection with the finance documents inclcuding principal interest fees costs and expenses and whether owed jointly or severally as principal or surety or in any othr capacity
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag
    Transactions
    • 21 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 25 mars 1998
    Livré le 27 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as trustee for iself and the banks as defined) under the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    All real property,any investment,goodwill and uncalled capital,money standing to the credit of any designated account for full details of all charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bhf-Bank Ag
    Transactions
    • 27 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 juin 1990
    Livré le 03 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 29.5.90 (as from time to time varied, extended, renewed or replaced) or in connection with the facility thereby granted on any variation extension renewal or replacement thereby including all loans or advances from time to time made to for or at the request of the company.
    Brèves mentions
    Naval row blackwall way, tower markets, l/b of tower hamlets title no egl 200588 and/or the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 juin 1990
    Livré le 03 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 29.5.90 (as from time to time varied, extended, renewed or replaced) or in connection with the facility thereby granted on any variation extension renewal or replacement thereby including all loans or advances from time to time made to for or at the request of the company.
    Brèves mentions
    Kensington village avon trading estate aranmore road, l/b of hammersmith & fulham title no ngl 621514 and/or the proceeds of sale thereof.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 sept. 1988
    Livré le 27 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    • 22 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 déc. 1987
    Livré le 17 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a land & buildings on the south side of navalrow and on the east side of blackwall way, london E14, title no. Egl 200588.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 22 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 déc. 1987
    Livré le 17 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a avon trading estate situate at avonmore road fulham, title no. Ngl 125133.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 22 déc. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    RYSBRIDGE ESTATES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 avr. 2013Commencement of winding up
    29 juin 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert James Harding
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Stephen Roland Browne
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    practitioner
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0