THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED

THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02335720
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Global House
    1 Ashley Avenue
    KT18 5FL Epsom
    Surrey
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2018

    11 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Charles Bentlif South le 01 juin 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr John Charles Bentlif South le 01 juin 2018

    1 pagesCH03

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Global House 1 Ashley Avenue Epsom Surrey KT18 5FL

    1 pagesAD04

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Valley View, Glebe Estate Glebe Estate Studland Swanage BH19 3AS England à Knighton House Ferry Road Studland Swanage BH19 3AQ

    1 pagesAD02

    Déclaration de confirmation établie le 17 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Valley View, Glebe Estate Glebe Estate Studland Swanage BH19 3AS

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Valley View, Glebe Estate Glebe Estate Studland Swanage BH19 3AS

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Valley View Glebe Estate Studland Dorset BH19 3AS à Global House 1 Ashley Avenue Epsom Surrey KT18 5FL le 22 sept. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 févr. 2016

    État du capital au 11 févr. 2016

    • Capital: GBP 850,022
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    9 pagesAA

    Statuts

    4 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Co need not hold an annual general meeting 06/03/2015
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 janv. 2015

    État du capital au 18 janv. 2015

    • Capital: GBP 850,022
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 févr. 2014

    État du capital au 12 févr. 2014

    • Capital: GBP 850,022
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    9 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SOUTH, John Charles Bentlif
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    England
    Secrétaire
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    England
    British21451100002
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Administrateur
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    SOUTH, John Charles Bentlif
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    England
    Administrateur
    Ferry Road
    Studland
    BH19 3AQ Swanage
    Knighton House
    England
    EnglandBritish21451100005
    FAITH, John Stephen
    The Granary
    Titchbourne Farm
    SP5 2JX Redlynch
    Wiltshire
    Secrétaire
    The Granary
    Titchbourne Farm
    SP5 2JX Redlynch
    Wiltshire
    British60500080001
    FATH, Wendy Butler
    Flat 4 Claremont Hall
    Highdale Road
    BS21 7LW Clevedon
    Avon
    Secrétaire
    Flat 4 Claremont Hall
    Highdale Road
    BS21 7LW Clevedon
    Avon
    British41883380001
    NOWELL, Stephen Gerrard
    Belmont Abson Road
    Pucklechurch
    BS16 9SD Bristol
    Secrétaire
    Belmont Abson Road
    Pucklechurch
    BS16 9SD Bristol
    British55554710001
    TREVELYAN, Michael Charles Edward
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    Secrétaire
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    British2706360001
    ZANT BOER, Ian
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    British80009300004
    COOK, Graham Ronald
    Barclosh
    DG5 4PL Dalbeattie
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    Barclosh
    DG5 4PL Dalbeattie
    Kirkcudbrightshire
    United KingdomBritish1233160001
    CORNISH, John Frederick Dadds
    Rosemont Church Road
    Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    Avon
    Administrateur
    Rosemont Church Road
    Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    Avon
    British19019770001
    FAITH, John Stephen
    The Granary
    Titchbourne Farm
    SP5 2JX Redlynch
    Wiltshire
    Administrateur
    The Granary
    Titchbourne Farm
    SP5 2JX Redlynch
    Wiltshire
    British60500080001
    HORSTED, James
    Deshure
    11a Ryecroft Way Stopsley
    LU2 7TU Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    Deshure
    11a Ryecroft Way Stopsley
    LU2 7TU Luton
    Bedfordshire
    British34994810002
    MANSFIELD, Linda Marjorie
    11 Hopkins Close
    Milton Keynes Village
    MK10 9AS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    11 Hopkins Close
    Milton Keynes Village
    MK10 9AS Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British42338210001
    NEAVES, Barry James
    40 Barrington Road
    NN10 0NJ Rushden
    Northamptonshire
    Administrateur
    40 Barrington Road
    NN10 0NJ Rushden
    Northamptonshire
    British44749950001
    SUMPTON, Elaine Mary
    1 Malcolm Drive
    NN5 5NN Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    1 Malcolm Drive
    NN5 5NN Northampton
    Northamptonshire
    British42468750001
    TREVELYAN, Michael Charles Edward
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    Administrateur
    12 Church Lane
    Backwell
    BS19 3PQ Bristol
    Avon
    British2706360001
    TYNAN, Anthony Patrick
    Keswick House Orchard Drive
    Weavering
    ME14 5JG Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Keswick House Orchard Drive
    Weavering
    ME14 5JG Maidstone
    Kent
    EnglandBritish4220230001
    TYNAN, Barry Thomas
    Two Oaks Faversham Road
    Charing
    TN27 0NS Ashford
    Kent
    Administrateur
    Two Oaks Faversham Road
    Charing
    TN27 0NS Ashford
    Kent
    United KingdomBritish3115490001
    WILLINGHAM, Steven Craig
    53 Rochelle Way
    Duston
    NN5 6YJ Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    53 Rochelle Way
    Duston
    NN5 6YJ Northampton
    Northamptonshire
    British63092720002
    WOOD, David James
    13 Vermuyden Way
    Fen Drayton
    CB4 5TA Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    13 Vermuyden Way
    Fen Drayton
    CB4 5TA Cambridge
    Cambridgeshire
    British19531650001
    ZANT BOER, Ian
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    Administrateur
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    EnglandBritish80009300004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    First Rented Housing Group Limited
    Ashley Avenue
    KT18 5FL Epsom
    Global House
    England
    06 avr. 2016
    Ashley Avenue
    KT18 5FL Epsom
    Global House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish
    Lieu d'enregistrementCardiff
    Numéro d'enregistrement02307652
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A standard security which was presented for registration in scotland on 21ST february 2003 and
    Créé le 14 févr. 2003
    Livré le 26 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    36 (1F2) william street edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 26 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 févr. 2003
    Livré le 21 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 21 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 14 févr. 2003
    Livré le 18 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold 41 crownfields grove green maidstone K670623 and the old mill salem road johnstown carmarthen CYM53889. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 18 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 06 mars 1998
    Livré le 14 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a 10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 and 23 hill house farm salisbury terrace norton stockton-on-tees t/nos CE116143 CE116144 CE116145 CE116146 for further details of title numbers see form 395. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 14 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 18 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2,4 & 6 meadowdown grove green maidstone kent, 4 & 11 haywain close maidstone, 7,25,39,41 & 45 crownfields grove green maidstone. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 18 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 17 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 4 meadowdown grove green maidstone kent t/n K670630 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 17 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 11 haywain close grove green maidstone kent t/n K680286 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 17 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 6 meadowdown grove green maidstone kent t/n K677013 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 17 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 25 crownfields grove green maidstone kent t/n K670625 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 17 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 7 crownfields grove green maidstone kent t/n K670626 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 17 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 39 crownfields grove green maidstone kent t/n K670627 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on that property and the goodwill of any business carried on on that property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 17 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 45 crownfields grove green maidstone kent t/no.K670631 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery goodwill of any business together with the benefit of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 17 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 41 crownfields grove green maidstone kent t/no.K670623 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery goodwill of any business together with the benefit of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 17 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 meadoedown grove green maidstone kent t/no.K670629 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery goodwill of any business together with the benefit of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third party charge
    Créé le 09 déc. 1996
    Livré le 17 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from everdon limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 4 haywain close grove geen maidstone kent t/no.K670632 and together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery goodwill of any business together with the benefit of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 21 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    THE KENTISH ASSURED PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 sept. 1994Declaration of solvency sworn on
    30 sept. 1994Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0