CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED

CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02350987
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suites 6-7 The Turvill Building Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STAFFORD HOUSE HOLDINGS LIMITED 22 févr. 198922 févr. 1989

    Quels sont les derniers comptes de CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 août 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 mai 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au22 mai 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation05 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au22 mai 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Christopher Alan James Stacey en tant que directeur le 18 août 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2023

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Feng Zhou en tant qu'administrateur le 10 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Hongru Zhou en tant qu'administrateur le 10 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2022

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Ruolei Niu en tant qu'administrateur le 04 avr. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Junil He en tant que directeur le 04 avr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Dong Mei Li en tant que directeur le 04 avr. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Alan James Stacey le 31 mai 2022

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Ceg Colleges Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2021

    2 pagesPSC05

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2021

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Elizabeth House High Street Chesterton Cambridge CB4 1NQ England à Suites 6-7 the Turvill Building Old Swiss 149 Cherry Hinton Road Cambridge CB1 7BX le 01 oct. 2021

    1 pagesAD01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 août 2020

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ms Dong Mei Li en tant qu'administrateur le 01 sept. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Junil He en tant qu'administrateur le 01 sept. 2020

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 50-60 Station Road Cambridge Cambridgeshire CB1 2JH United Kingdom à Elizabeth House High Street Chesterton Cambridge CB4 1NQ le 03 nov. 2020

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2019

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David Incesu Newton en tant que directeur le 31 mars 2020

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Incesu Newton le 01 oct. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Alan James Stacey le 01 oct. 2019

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NIU, Ruolei
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    Administrateur
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    Hong KongChineseDirector308048730001
    ZHOU, Feng
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    Administrateur
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    ChinaChineseDirector318497860001
    ZHOU, Hongru
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    Administrateur
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    ChinaChineseDirector318497280001
    SHAH, Harshitkumar Viryashchandra
    Station Road
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House
    Cambridgshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Station Road
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House
    Cambridgshire
    United Kingdom
    209585160001
    STANFIELD, Glynne
    Eversheds Llp
    Kett House Station Road
    CB1 2JY Cambridge
    Secrétaire
    Eversheds Llp
    Kett House Station Road
    CB1 2JY Cambridge
    British113309310001
    STANTON, Mark
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House Station Road
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House Station Road
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    British98669430001
    TAYLOR, Alan David
    139 Copse Hill
    Wimbledon
    SW20 0SU London
    Secrétaire
    139 Copse Hill
    Wimbledon
    SW20 0SU London
    British11835440001
    TRAVERS, Dominic Jon
    27 Mawson Road
    CB1 2DZ Cambridge
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    27 Mawson Road
    CB1 2DZ Cambridge
    Cambridgeshire
    British50011070002
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    TRUSEC LIMITED
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    Secrétaire désigné
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    900007200001
    ARMSTRONG, Elizabeth Ruth
    48 Maids Causeway
    CB5 8DD Cambridge
    Administrateur
    48 Maids Causeway
    CB5 8DD Cambridge
    BritishEducationalist26162370002
    BROWNLEE, Fergus Stuart
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House Station Road
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Administrateur
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House Station Road
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive Officer245666040001
    ELMAHROUKI, Mohamed Sherif Ahmed
    Orchard Cottage Denton Lane
    Wootton
    CT4 6RN Canterbury
    Kent
    Administrateur
    Orchard Cottage Denton Lane
    Wootton
    CT4 6RN Canterbury
    Kent
    United KingdomBritishFinance Director35561440002
    GOLDING, Nicholas Philip Dunstan, Mr.
    25 Storeys Way
    CB3 0DP Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    25 Storeys Way
    CB3 0DP Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishCompany Director12099760003
    HE, Junil
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    Administrateur
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    ChinaAmericanCeo276097470001
    IOAKIMIDES, Michael
    Station Road
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House
    Cambridgshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Station Road
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House
    Cambridgshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCeo245667300001
    LI, Dong Mei
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    Administrateur
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    ChinaChineseCfo248971140001
    LOTHIAN, Stuart Laird
    7 Macfarlane Close
    Impington
    CB4 9LZ Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    7 Macfarlane Close
    Impington
    CB4 9LZ Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritishCompany Director2765420001
    NEWTON, David Incesu
    Station Road
    CB1 2JH Cambridge
    50-60
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Station Road
    CB1 2JH Cambridge
    50-60
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCeo256327600001
    SHAH, Harshitkumar Viryashchandra
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House Station Road
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Administrateur
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House Station Road
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer321554560001
    STACEY, Christopher Alan James
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    Administrateur
    Old Swiss
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7 The Turvill Building
    England
    EnglandBritishCeo256327610001
    STANTON, Mark
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House Station Road
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Administrateur
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House Station Road
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant98669430001
    SYMES, Philip Leslie
    Station Road
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House
    Cambridgshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Station Road
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House
    Cambridgshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer182939460001
    TAYLOR, Alan David
    139 Copse Hill
    Wimbledon
    SW20 0SU London
    Administrateur
    139 Copse Hill
    Wimbledon
    SW20 0SU London
    United KingdomBritishSolicitor11835440001
    WEBB, Brendan Grant
    Station Road
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House
    Administrateur
    Station Road
    CB1 2JH Cambridge
    Kett House
    United KingdomBritishDirector225410450001
    WOOLF, Richard Anthony
    11 Nightingale Close
    HA5 2TN Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    11 Nightingale Close
    HA5 2TN Pinner
    Middlesex
    BritishMarketing Consultant42772990001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7, The Turvill Building, Old Swiss
    England
    06 avr. 2016
    149 Cherry Hinton Road
    CB1 7BX Cambridge
    Suites 6-7, The Turvill Building, Old Swiss
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06355623
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2008
    Livré le 08 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 12 août 1998
    Livré le 02 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 10 sept. 1997
    Livré le 19 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 7 & 9 ethelbert road canterbury kent t/n K728654 and K728656. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 août 1996
    Livré le 13 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 56 new dover road canterbury kent t/no.K440732 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 août 1996
    Livré le 13 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 8 & 9 oaten hill canterbury kent t/no.K180296 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 17 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 58-60 new dover road k/a annie purchas house canterbury kent t/no K161412 K309839 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 06 nov. 1995
    Livré le 16 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a flat 2-22 st stephens road canterbury kent and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 nov. 1989
    Livré le 17 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    68 new dover road canterbury kent title no K279583 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 13 avr. 1989
    Livré le 25 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0