CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02350987 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?
Adresse du siège social | Suites 6-7 The Turvill Building Old Swiss 149 Cherry Hinton Road CB1 7BX Cambridge England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 août 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 mai 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 22 mai 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 05 juin 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 22 mai 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Christopher Alan James Stacey en tant que directeur le 18 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2023 | 6 pages | AA | ||
Nomination de Mr Feng Zhou en tant qu'administrateur le 10 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Hongru Zhou en tant qu'administrateur le 10 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2022 | 6 pages | AA | ||
Nomination de Mr Ruolei Niu en tant qu'administrateur le 04 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Junil He en tant que directeur le 04 avr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Dong Mei Li en tant que directeur le 04 avr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Alan James Stacey le 31 mai 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des détails de Ceg Colleges Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2021 | 6 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Elizabeth House High Street Chesterton Cambridge CB4 1NQ England à Suites 6-7 the Turvill Building Old Swiss 149 Cherry Hinton Road Cambridge CB1 7BX le 01 oct. 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 août 2020 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Ms Dong Mei Li en tant qu'administrateur le 01 sept. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Junil He en tant qu'administrateur le 01 sept. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 50-60 Station Road Cambridge Cambridgeshire CB1 2JH United Kingdom à Elizabeth House High Street Chesterton Cambridge CB4 1NQ le 03 nov. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2019 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de David Incesu Newton en tant que directeur le 31 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur David Incesu Newton le 01 oct. 2019 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Christopher Alan James Stacey le 01 oct. 2019 | 2 pages | CH01 | ||
Qui sont les dirigeants de CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIU, Ruolei | Administrateur | Old Swiss 149 Cherry Hinton Road CB1 7BX Cambridge Suites 6-7 The Turvill Building England | Hong Kong | Chinese | Director | 308048730001 | ||||
ZHOU, Feng | Administrateur | Old Swiss 149 Cherry Hinton Road CB1 7BX Cambridge Suites 6-7 The Turvill Building England | China | Chinese | Director | 318497860001 | ||||
ZHOU, Hongru | Administrateur | Old Swiss 149 Cherry Hinton Road CB1 7BX Cambridge Suites 6-7 The Turvill Building England | China | Chinese | Director | 318497280001 | ||||
SHAH, Harshitkumar Viryashchandra | Secrétaire | Station Road CB1 2JH Cambridge Kett House Cambridgshire United Kingdom | 209585160001 | |||||||
STANFIELD, Glynne | Secrétaire | Eversheds Llp Kett House Station Road CB1 2JY Cambridge | British | 113309310001 | ||||||
STANTON, Mark | Secrétaire | CB1 2JH Cambridge Kett House Station Road Cambridgeshire United Kingdom | British | 98669430001 | ||||||
TAYLOR, Alan David | Secrétaire | 139 Copse Hill Wimbledon SW20 0SU London | British | 11835440001 | ||||||
TRAVERS, Dominic Jon | Secrétaire | 27 Mawson Road CB1 2DZ Cambridge Cambridgeshire | British | 50011070002 | ||||||
EVERSECRETARY LIMITED | Secrétaire | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
TRUSEC LIMITED | Secrétaire désigné | 2 Lambs Passage EC1Y 8BB London | 900007200001 | |||||||
ARMSTRONG, Elizabeth Ruth | Administrateur | 48 Maids Causeway CB5 8DD Cambridge | British | Educationalist | 26162370002 | |||||
BROWNLEE, Fergus Stuart | Administrateur | CB1 2JH Cambridge Kett House Station Road Cambridgeshire United Kingdom | England | British | Chief Executive Officer | 245666040001 | ||||
ELMAHROUKI, Mohamed Sherif Ahmed | Administrateur | Orchard Cottage Denton Lane Wootton CT4 6RN Canterbury Kent | United Kingdom | British | Finance Director | 35561440002 | ||||
GOLDING, Nicholas Philip Dunstan, Mr. | Administrateur | 25 Storeys Way CB3 0DP Cambridge Cambridgeshire | United Kingdom | British | Company Director | 12099760003 | ||||
HE, Junil | Administrateur | Old Swiss 149 Cherry Hinton Road CB1 7BX Cambridge Suites 6-7 The Turvill Building England | China | American | Ceo | 276097470001 | ||||
IOAKIMIDES, Michael | Administrateur | Station Road CB1 2JH Cambridge Kett House Cambridgshire United Kingdom | United Kingdom | British | Ceo | 245667300001 | ||||
LI, Dong Mei | Administrateur | Old Swiss 149 Cherry Hinton Road CB1 7BX Cambridge Suites 6-7 The Turvill Building England | China | Chinese | Cfo | 248971140001 | ||||
LOTHIAN, Stuart Laird | Administrateur | 7 Macfarlane Close Impington CB4 9LZ Cambridge Cambridgeshire | England | British | Company Director | 2765420001 | ||||
NEWTON, David Incesu | Administrateur | Station Road CB1 2JH Cambridge 50-60 Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | Ceo | 256327600001 | ||||
SHAH, Harshitkumar Viryashchandra | Administrateur | CB1 2JH Cambridge Kett House Station Road Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 321554560001 | ||||
STACEY, Christopher Alan James | Administrateur | Old Swiss 149 Cherry Hinton Road CB1 7BX Cambridge Suites 6-7 The Turvill Building England | England | British | Ceo | 256327610001 | ||||
STANTON, Mark | Administrateur | CB1 2JH Cambridge Kett House Station Road Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 98669430001 | ||||
SYMES, Philip Leslie | Administrateur | Station Road CB1 2JH Cambridge Kett House Cambridgshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 182939460001 | ||||
TAYLOR, Alan David | Administrateur | 139 Copse Hill Wimbledon SW20 0SU London | United Kingdom | British | Solicitor | 11835440001 | ||||
WEBB, Brendan Grant | Administrateur | Station Road CB1 2JH Cambridge Kett House | United Kingdom | British | Director | 225410450001 | ||||
WOOLF, Richard Anthony | Administrateur | 11 Nightingale Close HA5 2TN Pinner Middlesex | British | Marketing Consultant | 42772990001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceg Colleges Limited | 06 avr. 2016 | 149 Cherry Hinton Road CB1 7BX Cambridge Suites 6-7, The Turvill Building, Old Swiss England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 24 juil. 2008 Livré le 08 août 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 12 août 1998 Livré le 02 sept. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 10 sept. 1997 Livré le 19 sept. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/a 7 & 9 ethelbert road canterbury kent t/n K728654 and K728656. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 06 août 1996 Livré le 13 août 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a 56 new dover road canterbury kent t/no.K440732 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 06 août 1996 Livré le 13 août 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a 8 & 9 oaten hill canterbury kent t/no.K180296 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 29 mars 1996 Livré le 17 avr. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 58-60 new dover road k/a annie purchas house canterbury kent t/no K161412 K309839 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 06 nov. 1995 Livré le 16 nov. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The l/h property k/a flat 2-22 st stephens road canterbury kent and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 09 nov. 1989 Livré le 17 nov. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 68 new dover road canterbury kent title no K279583 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 13 avr. 1989 Livré le 25 avr. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0