GIBB HOLDINGS LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGIBB HOLDINGS LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02387714
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GIBB HOLDINGS LTD ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe GIBB HOLDINGS LTD ?

    Adresse du siège social
    Cottons Centre
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GIBB HOLDINGS LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GIBB LIMITED18 sept. 198918 sept. 1989
    CHULSAVALE LIMITED22 mai 198922 mai 1989

    Quels sont les derniers comptes de GIBB HOLDINGS LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 oct. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour GIBB HOLDINGS LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Nomination de Mr Geoffrey Roberts en tant que secrétaire le 21 août 2023

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Rhona Mary Holman en tant que secrétaire le 21 août 2023

    1 pagesTM02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    État du capital au 29 juin 2023

    • Capital: GBP 0.40412
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Rhona Mary Holman en tant que secrétaire le 10 févr. 2023

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Tejender Singh Chaudhary en tant que secrétaire le 10 févr. 2023

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 20 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Katherine Helen Kenny en tant qu'administrateur le 15 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Hugh Donald Morrison en tant que directeur le 15 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 01 oct. 2021

    24 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 02 oct. 2020

    26 pagesAA

    Nomination de Mrs Sally Miles en tant qu'administrateur le 11 août 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Guy Douglas en tant que directeur le 11 août 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 20 janv. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2019

    26 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jonathan R. Shattock en tant que directeur le 30 nov. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Hugh Donald Morrison en tant qu'administrateur le 30 nov. 2020

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Guy Douglas le 17 déc. 2020

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Jacobs Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 nov. 2020

    2 pagesPSC05

    Qui sont les dirigeants de GIBB HOLDINGS LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROBERTS, Geoffrey
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    312725290001
    KENNY, Katherine Helen
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish216980410001
    MILES, Sally Linda Joyce
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish161125950001
    CHAUDHARY, Tejender Singh
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    246698880001
    HOLMAN, Rhona Mary
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    305629180001
    MARKLEY, William Clyde
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    Secrétaire
    2105 Sunnybank Drive
    La Canada
    91011 Flintridge
    California
    United States Of America
    American57955380001
    NORRIS, Michael Timothy
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    British52563600002
    UDOVIC, Michael Sean
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    165335900001
    WARD, Sandra Lesley
    17 Clayfields
    HP10 8AT Tylers Green
    Bucks
    Secrétaire
    17 Clayfields
    HP10 8AT Tylers Green
    Bucks
    British89320390001
    WITHERS, Graham Reginald
    33 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    33 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    British1420080001
    BACK, Paul Adrian Auchmuty, Dr
    Parsonage Farm
    How Lane
    SL6 3JP White Waltham
    Berkshire
    Administrateur
    Parsonage Farm
    How Lane
    SL6 3JP White Waltham
    Berkshire
    British22932520001
    BARBER, Walter Charles
    61 Riverside House
    Bear Wharf Fobney Street
    RG1 6BJ Reading
    Berkshire
    Administrateur
    61 Riverside House
    Bear Wharf Fobney Street
    RG1 6BJ Reading
    Berkshire
    American93663320001
    BOWCOCK, John Brown
    Lothlorien
    Crowsley Road
    RG9 3JU Shiplake
    Oxfordshire
    Administrateur
    Lothlorien
    Crowsley Road
    RG9 3JU Shiplake
    Oxfordshire
    British34950050001
    BRETTELL, Peter Donald
    Blorenge Cottage
    Holly Lane Ashampstead
    RG8 8RT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Blorenge Cottage
    Holly Lane Ashampstead
    RG8 8RT Reading
    Berkshire
    British34455550003
    BRICE, Geoffrey John
    3 Orwell Close
    Caversham
    RG4 7PU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    3 Orwell Close
    Caversham
    RG4 7PU Reading
    Berkshire
    British7239880001
    COATES, Geoffrey Hamilton
    The Shealing
    Backsideans Wargrave-On-Thames
    RG10 8JP Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Shealing
    Backsideans Wargrave-On-Thames
    RG10 8JP Reading
    Berkshire
    British1420060001
    COLES, Bruce Charles
    703 Henley Fields Circle
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30155
    Usa
    Administrateur
    703 Henley Fields Circle
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30155
    Usa
    American49990460001
    DANGER, James Ivan
    2694 Northbrook Drive
    Atlanta
    FOREIGN Georgia 30340
    Usa
    Administrateur
    2694 Northbrook Drive
    Atlanta
    FOREIGN Georgia 30340
    Usa
    American43472160001
    DAWSON, James Grant Forbes
    Woodpeckers
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    Administrateur
    Woodpeckers
    Pangbourne Hill
    RG8 8JS Pangbourne
    Berkshire
    British32689240001
    DOUGLAS, Guy
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish258025190001
    DOYLE, John Conor
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish78009780001
    DUFF, Robert Shepherd
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish165632810001
    ELLIS, David
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United KingdomBritish206422550001
    FOOSHEE, Robert Brown
    9000 Etching Overlook Drive
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30097
    Usa
    Administrateur
    9000 Etching Overlook Drive
    FOREIGN Duluth
    Georgia 30097
    Usa
    American49990480001
    HENNESSEY, John Richard
    Folly Farm
    Barkham Road
    RG11 4BS Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Folly Farm
    Barkham Road
    RG11 4BS Wokingham
    Berkshire
    British22928530001
    IRVIN, Robert Anthony Michael
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish161055320001
    JONES, Graham Roger
    Coningsby 81 The Rise
    TN13 1RN Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Coningsby 81 The Rise
    TN13 1RN Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish42069750001
    MONTGOMERY, Michael Wayne
    Red Fox Cottage
    Old Bath Road Sonning
    RG4 0TA Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Red Fox Cottage
    Old Bath Road Sonning
    RG4 0TA Reading
    Berkshire
    American32725930002
    MORRISON, Hugh Donald
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish240150920001
    SEHGAL, Raghbir Kumar
    55 Cliffside Crossing
    Atlanta
    Georgia Ga 30338
    Usa
    Administrateur
    55 Cliffside Crossing
    Atlanta
    Georgia Ga 30338
    Usa
    American32725940001
    SHATTOCK, Jonathan R.
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish259549880001
    STANCOMBE, Christopher John
    8 Wellington Gardens
    Southend Bradfield
    RG7 6EJ Reading
    Berkshire
    Administrateur
    8 Wellington Gardens
    Southend Bradfield
    RG7 6EJ Reading
    Berkshire
    EnglandBritish33841950002
    STEINBRENNER, Frederick James
    5707 Brynwood Circle
    30101 Georgia
    Usa
    Administrateur
    5707 Brynwood Circle
    30101 Georgia
    Usa
    American7239910004
    TAYLOR, Allyn Byram
    Mill Lane
    Cookham
    SL6 9QT Maidenhead
    Formosa Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Mill Lane
    Cookham
    SL6 9QT Maidenhead
    Formosa Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandUnited States124922150002
    WALKER, William Allen
    3345 Robinson Farms Court
    Marietta
    FOREIGN Atlanta
    Georgia Ga 30068
    Usa
    Administrateur
    3345 Robinson Farms Court
    Marietta
    FOREIGN Atlanta
    Georgia Ga 30068
    Usa
    American15467690004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GIBB HOLDINGS LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Jacobs Uk Limited
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland Companies Registry
    Numéro d'enregistrement02594504
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GIBB HOLDINGS LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of rectification and supplemental charge
    Créé le 03 nov. 1995
    Livré le 22 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    13% of the issued share capital of prointec sa being: 300,000 pesetas............................13 Common stock of pesetas,100,000 numbered 8-18 and 21 and 94; all stocks,shares,bonds,debentures,notes...etc..........all dividends/other income and all rights,benefits,money or property..................all repayments of principal on loan notes.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Suntrust Bank,Atlanta
    Transactions
    • 22 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 13 oct. 1995
    Livré le 18 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 11 oct. 1995
    Livré le 18 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to suntrust bank,atlanta for itself and as agent and trustee on behalf of the lenders (as defined)to each lender in any currency and whether or not the lender in question shall have been a party to the original transaction except any money or liabilities due by any company as guarantor for the depositor
    Brèves mentions
    The securities all dividends distributions interest and other income all accretions of a capital nature and all capital sums received. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Suntrust Bank Atlanta
    Transactions
    • 18 oct. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First charge
    Créé le 08 oct. 1993
    Livré le 13 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities (i)of law companies group,inc.to trust company bank and other banks under a credit agreement dated 8 october 1993 (us$42,000,000 together with interest,charges and costs)(ii)of law companies group,inc.to trust company bank under a reimbursement agreement dated 8 october 1993 (all amounts due under letters of credit issued by trust company bank)(iii)of law companies group,inc.and sir alexander gibb & partners limited to barclays bank PLC under a facility letter dated 8 october 1993 (£16,900,000 together with interest charges and costs)(iv)of gibb limited to barclays bank PLC under a commercial mortgage facility letter dated 8 february 1990 (£495,900 together with interest charges and costs) and (v)the obligations of certain partnerships and companies defined as sir alexander gibb partnerships to barclays bank PLC (£2,000,000 together with interest,charges and costs)and amounts due under the indemnity contained in clause 15.3 of the first charge
    Brèves mentions
    2,217,800 shares of £1 each in sir alexander gibb & partners limited together with any substituted or additional shares or other securities and further including all allotments,accretions,offers,voting or other rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Trust Company Bankertain Other Banksas Collateral Agent and Trustee for Itself and C
    Transactions
    • 13 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mars 1990
    Livré le 07 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat 5, 2 hyde park street, london W2. Title no. Ngl 617261.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 31 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 août 1989
    Livré le 24 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transactions
    • 24 août 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0