Michael Timothy NORRIS
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | Michael |
Deuxième prénom | Timothy |
Nom de famille | NORRIS |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 7 |
Démissionné | 9 |
Total | 16 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABTIE INTERNATIONAL LIMITED | 13 déc. 2005 | Dissoute | Secrétaire | 95 Bothwell Street Glasgow G2 7HX | British | |||
INSPIRE DEFENCE LIMITED | 10 oct. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | |||
JACOBS SKM LIMITED | 27 sept. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | |||
PARTNERS FOR INFRASTRUCTURE LIMITED | 27 sept. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | |||
GIBB LTD | 30 juin 1999 | Dissoute | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | |||
GIBB OVERSEAS LIMITED | 30 juin 1999 | Dissoute | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | |||
NICK DERBYSHIRE DESIGN ASSOCIATES LIMITED | 30 juin 1999 | Dissoute | Secrétaire | 8 Meadow Lane RG8 7NB Pangbourne Berkshire | British | |||
BABTIE SHAW & MORTON LIMITED | 13 déc. 2005 | 23 mai 2018 | Dissoute | Secrétaire | 95 Bothwell Street Glasgow G2 7HX Strathclyde | British | ||
JACOBS EUROPEAN HOLDINGS LIMITED | 27 sept. 2005 | 23 mai 2018 | Dissoute | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | ||
LEIGHFISHER U.K. LIMITED | 27 sept. 2005 | 23 mai 2018 | Dissoute | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | ||
JACOBS ONE LIMITED | 12 août 2004 | 23 mai 2018 | Active | Company Secretary | Secrétaire | 95 Bothwell Street Glasgow G2 7HX | British | |
WESTMINSTER AND EARLEY SERVICES LIMITED | 30 juin 1999 | 23 mai 2018 | Dissoute | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire | British | ||
JACOBSGIBB LTD | 30 juin 1999 | 23 mai 2018 | Active | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | ||
GIBB HOLDINGS LTD | 30 juin 1999 | 23 mai 2018 | Dissoute | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TU Wokingham 1180 Berkshire United Kingdom | British | ||
GIBB LTD | 29 mai 2001 | 06 avr. 2005 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | 7 The Moors Pangbourne RG8 7LP Reading Berkshire | British | |
JACOBSGIBB LTD | 01 avr. 1997 | 04 nov. 2002 | Active | Company Director | Administrateur | 7 The Moors Pangbourne RG8 7LP Reading Berkshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0