ASCRIBE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéASCRIBE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02394847
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ASCRIBE LIMITED ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication

    Où se situe ASCRIBE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Pkf Gm, 3rd Floor
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ASCRIBE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ASC COMPUTER SOFTWARE LIMITED14 juin 198914 juin 1989

    Quels sont les derniers comptes de ASCRIBE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour ASCRIBE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    16 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 sept. 2023

    18 pagesLIQ03

    État du capital au 10 oct. 2022

    • Capital: GBP 0.01
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel; share prem a/c 23/08/2022
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Changement d'adresse du siège social de Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA England à Pkf Gm, 3rd Floor One Park Row Leeds LS1 5HN le 03 oct. 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 sept. 2022

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 23/08/2022
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Deuxième dépôt pour la nomination de Mr Paul Stewart en tant qu'administrateur

    3 pagesRP04AP01

    Nomination de Mr Paul Stewart en tant qu'administrateur le 20 juil. 2022

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    25 juil. 2022Clarification A second filed AP01 was registered on 25/07/22

    Cessation de la nomination de Andrew John Thorburn en tant que directeur le 20 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Suzanne Marie Foster en tant que directeur le 20 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    30 pagesAA

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 pagesAD04

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 pagesAD04

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA England à Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    28 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ASCRIBE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BENSON, Christine
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    Secrétaire
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    239350110001
    SOUTHBY, Peter John
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    Administrateur
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    EnglandBritish116859780002
    STEWART, Paul
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    Administrateur
    One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    Pkf Gm, 3rd Floor
    EnglandBritish262072580001
    FARBRIDGE, Caroline Louise
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Secrétaire
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    193500130001
    JONES, Christopher Kenneth
    12 Cherry Tree Avenue
    WA13 0NS Lymm
    Cheshire
    Secrétaire
    12 Cherry Tree Avenue
    WA13 0NS Lymm
    Cheshire
    English29059120001
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    Secrétaire
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    British98814590001
    MOTTRAM, Mandy Joanne
    Constable Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BG Stockport
    18
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Constable Drive
    Marple Bridge
    SK6 5BG Stockport
    18
    Cheshire
    England
    166860490001
    RUSCOE, Antony Myles
    21 Sycamore Close
    Endmoor
    LA8 0NY Kendal
    Cumbria
    Secrétaire
    21 Sycamore Close
    Endmoor
    LA8 0NY Kendal
    Cumbria
    British49371150003
    WAITE, Simon Nicholas
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    Secrétaire
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    213728810001
    BRADSHAW, Arthur Richard
    4 The Spinney
    Horrobin Lane Turton
    BL7 0JA Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    4 The Spinney
    Horrobin Lane Turton
    BL7 0JA Bolton
    Lancashire
    British5411670002
    CRITCHLOW, Anthony Stephen
    Grange Farm
    Grange Road Bromley Cross
    BL7 9AX Bolton
    Administrateur
    Grange Farm
    Grange Road Bromley Cross
    BL7 9AX Bolton
    United KingdomBritish101716720002
    DICKSON, Christopher John
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Administrateur
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish100748280003
    FOSTER, Suzanne Marie
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Administrateur
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    EnglandBritish262072440001
    GARRINGTON, Stephen John
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    15 Chesterton Close
    Hunt End
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    British45513680001
    HUGHES, David Michael
    Lea House
    Patshull Road, Albrighton
    WV7 3BH Wolverhampton
    Administrateur
    Lea House
    Patshull Road, Albrighton
    WV7 3BH Wolverhampton
    EnglandBritish12292930002
    JOHNSON, Paul Thomas
    51 Glebe Lane
    ST20 0HG Gnosall
    Staffordshire
    Administrateur
    51 Glebe Lane
    ST20 0HG Gnosall
    Staffordshire
    British74821110001
    JONES, Christopher Kenneth
    43 Moorland Drive Rise
    Haslingden
    BB4 6UA Rossendale
    Lancashire
    Administrateur
    43 Moorland Drive Rise
    Haslingden
    BB4 6UA Rossendale
    Lancashire
    English29059120002
    KELLY, Mark William
    129 Regent Road
    BL6 4DX Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    129 Regent Road
    BL6 4DX Bolton
    Lancashire
    British79084160001
    LAWRENCE, Duane Stephen
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Administrateur
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish,American195658640003
    LEE, Jeremy Stephen William
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    Administrateur
    10 Hodge Fold
    SK14 6BL Broadbottom
    Cheshire
    United KingdomBritish98814590001
    MELLOR, Marcus Irving
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Administrateur
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandUnited Kingdom156959810001
    RUSCOE, Antony Myles
    21 Sycamore Close
    Endmoor
    LA8 0NY Kendal
    Cumbria
    Administrateur
    21 Sycamore Close
    Endmoor
    LA8 0NY Kendal
    Cumbria
    UkBritish49371150003
    SALTER, Richard Leonard James
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Administrateur
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish181746490001
    SPENCER, Christopher Michael Kennedy
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Administrateur
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish4742550002
    STENTON, Raymond
    2 Old Hall Lane
    Worsley
    M28 2FG Manchester
    Administrateur
    2 Old Hall Lane
    Worsley
    M28 2FG Manchester
    British97198410001
    TAMBLYN, Christina
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    Administrateur
    Green Lane
    Yeadon
    LS19 7BY Leeds
    Rawdon House
    England
    EnglandBritish191028210001
    TAYLOR, Ian Albert
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Administrateur
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    United KingdomBritish237425740001
    THORBURN, Andrew John
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Administrateur
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    United KingdomBritish124801800001
    TOWNEND, Nicholas Adam
    Ascribe House Branker Street
    Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    Ascribe House Branker Street
    Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish154577090001
    WILLIAMS, Jane
    163 Smithy Lane
    L40 8HJ Scarisbrick
    Lancashire
    Administrateur
    163 Smithy Lane
    L40 8HJ Scarisbrick
    Lancashire
    British79289770001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASCRIBE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    06 avr. 2016
    Micklefield Lane
    Rawdon
    LS19 6BA Leeds
    Fulford Grange
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05204003
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ASCRIBE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 01 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Eci Ventures Nominees Limited
    Transactions
    • 01 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 01 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    A specific security deed
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 01 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The securities, the rights, all proceeds of any securities or rights and all documents of the title relating to any securities or rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Yorkshire Bank (A Trading Name of Clydesdale Bank PLC)
    Transactions
    • 01 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of mortgage of marketable securities
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 01 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the issued capital of asc computer software pty. LTD (abn 75 075 121 028) held by the mortgagor, which as at the date of the deed consists of 1,000 fully paid ordinary shares of $1.00 each see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 01 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 mars 2006
    Livré le 17 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 17 juin 1997
    Livré le 19 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    ASCRIBE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 sept. 2022Commencement of winding up
    10 avr. 2024Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    James Sleight
    3rd Floor One Park Row
    LS1 5HN Leeds
    practitioner
    3rd Floor One Park Row
    LS1 5HN Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0