ASCRIBE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ASCRIBE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02394847 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ASCRIBE LIMITED ?
| Adresse du siège social | Pkf Gm, 3rd Floor One Park Row LS1 5HN Leeds |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ASCRIBE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour ASCRIBE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 16 pages | LIQ13 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 sept. 2023 | 18 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
État du capital au 10 oct. 2022
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA England à Pkf Gm, 3rd Floor One Park Row Leeds LS1 5HN le 03 oct. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 6 pages | LIQ01 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Deuxième dépôt pour la nomination de Mr Paul Stewart en tant qu'administrateur | 3 pages | RP04AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Stewart en tant qu'administrateur le 20 juil. 2022 | 3 pages | AP01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew John Thorburn en tant que directeur le 20 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Suzanne Marie Foster en tant que directeur le 20 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 30 pages | AA | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA | 1 pages | AD04 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA | 1 pages | AD04 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 6 Airport West Lancaster Way Yeadon Leeds LS19 7ZA England à Fulford Grange Micklefield Lane Rawdon Leeds LS19 6BA | 1 pages | AD02 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 28 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de ASCRIBE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENSON, Christine | Secrétaire | One Park Row LS1 5HN Leeds Pkf Gm, 3rd Floor | 239350110001 | |||||||
| SOUTHBY, Peter John | Administrateur | One Park Row LS1 5HN Leeds Pkf Gm, 3rd Floor | England | British | 116859780002 | |||||
| STEWART, Paul | Administrateur | One Park Row LS1 5HN Leeds Pkf Gm, 3rd Floor | England | British | 262072580001 | |||||
| FARBRIDGE, Caroline Louise | Secrétaire | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | 193500130001 | |||||||
| JONES, Christopher Kenneth | Secrétaire | 12 Cherry Tree Avenue WA13 0NS Lymm Cheshire | English | 29059120001 | ||||||
| LEE, Jeremy Stephen William | Secrétaire | 10 Hodge Fold SK14 6BL Broadbottom Cheshire | British | 98814590001 | ||||||
| MOTTRAM, Mandy Joanne | Secrétaire | Constable Drive Marple Bridge SK6 5BG Stockport 18 Cheshire England | 166860490001 | |||||||
| RUSCOE, Antony Myles | Secrétaire | 21 Sycamore Close Endmoor LA8 0NY Kendal Cumbria | British | 49371150003 | ||||||
| WAITE, Simon Nicholas | Secrétaire | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House | 213728810001 | |||||||
| BRADSHAW, Arthur Richard | Administrateur | 4 The Spinney Horrobin Lane Turton BL7 0JA Bolton Lancashire | British | 5411670002 | ||||||
| CRITCHLOW, Anthony Stephen | Administrateur | Grange Farm Grange Road Bromley Cross BL7 9AX Bolton | United Kingdom | British | 101716720002 | |||||
| DICKSON, Christopher John | Administrateur | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | 100748280003 | |||||
| FOSTER, Suzanne Marie | Administrateur | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | England | British | 262072440001 | |||||
| GARRINGTON, Stephen John | Administrateur | 15 Chesterton Close Hunt End B97 5XS Redditch Worcestershire | British | 45513680001 | ||||||
| HUGHES, David Michael | Administrateur | Lea House Patshull Road, Albrighton WV7 3BH Wolverhampton | England | British | 12292930002 | |||||
| JOHNSON, Paul Thomas | Administrateur | 51 Glebe Lane ST20 0HG Gnosall Staffordshire | British | 74821110001 | ||||||
| JONES, Christopher Kenneth | Administrateur | 43 Moorland Drive Rise Haslingden BB4 6UA Rossendale Lancashire | English | 29059120002 | ||||||
| KELLY, Mark William | Administrateur | 129 Regent Road BL6 4DX Bolton Lancashire | British | 79084160001 | ||||||
| LAWRENCE, Duane Stephen | Administrateur | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British,American | 195658640003 | |||||
| LEE, Jeremy Stephen William | Administrateur | 10 Hodge Fold SK14 6BL Broadbottom Cheshire | United Kingdom | British | 98814590001 | |||||
| MELLOR, Marcus Irving | Administrateur | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | United Kingdom | 156959810001 | |||||
| RUSCOE, Antony Myles | Administrateur | 21 Sycamore Close Endmoor LA8 0NY Kendal Cumbria | Uk | British | 49371150003 | |||||
| SALTER, Richard Leonard James | Administrateur | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | 181746490001 | |||||
| SPENCER, Christopher Michael Kennedy | Administrateur | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | 4742550002 | |||||
| STENTON, Raymond | Administrateur | 2 Old Hall Lane Worsley M28 2FG Manchester | British | 97198410001 | ||||||
| TAMBLYN, Christina | Administrateur | Green Lane Yeadon LS19 7BY Leeds Rawdon House England | England | British | 191028210001 | |||||
| TAYLOR, Ian Albert | Administrateur | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | United Kingdom | British | 237425740001 | |||||
| THORBURN, Andrew John | Administrateur | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | United Kingdom | British | 124801800001 | |||||
| TOWNEND, Nicholas Adam | Administrateur | Ascribe House Branker Street Westhoughton BL5 3JD Bolton Lancashire | England | British | 154577090001 | |||||
| WILLIAMS, Jane | Administrateur | 163 Smithy Lane L40 8HJ Scarisbrick Lancashire | British | 79289770001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ASCRIBE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascribe Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Micklefield Lane Rawdon LS19 6BA Leeds Fulford Grange England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
ASCRIBE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Créé le 26 mars 2009 Livré le 01 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 mars 2009 Livré le 01 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A specific security deed | Créé le 26 mars 2009 Livré le 01 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The securities, the rights, all proceeds of any securities or rights and all documents of the title relating to any securities or rights see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A deed of mortgage of marketable securities | Créé le 26 mars 2009 Livré le 01 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of the issued capital of asc computer software pty. LTD (abn 75 075 121 028) held by the mortgagor, which as at the date of the deed consists of 1,000 fully paid ordinary shares of $1.00 each see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 mars 2006 Livré le 17 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 17 juin 1997 Livré le 19 juin 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
ASCRIBE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0