TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 02587396 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Cast House Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Nomination de Mrs Penny Fullerton en tant que secrétaire le 24 mars 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Blott en tant que secrétaire le 24 mars 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Peter John Hubbard en tant que directeur le 29 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Blott en tant que secrétaire le 01 nov. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeffrey Christopher Orton en tant que secrétaire le 01 nov. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Warren en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Warren en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Jeffrey Christopher Orton en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Penelope Fullerton en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Ryan Mark Gill en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Penelope Jane Fullerton en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stacey Zaczkiewicz en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLERTON, Penny | Secrétaire | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 206865730001 | |||||||
| BEALES, Karen Anne | Administrateur | Marling Road Ainley Top HD2 2EE Huddersfield The Chalet Uk | England | British | 135540180002 | |||||
| GILL, Ryan Mark | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 184068890001 | |||||
| SMITH, Malachy Paul | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | Ireland | Irish | 262619320001 | |||||
| BLOOM, Colin Preston Paul | Secrétaire | 27 Woodfields Stradbroke IP21 5JQ Eye Suffolk | British | 21182260001 | ||||||
| BLOTT, Stephen | Secrétaire | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 202286490001 | |||||||
| BLOTT, Stephen | Secrétaire | Low Wood Wilsden BD15 0JS Bradford 30 West Yorkshire England | British | 139352410001 | ||||||
| FULLERTON, Penelope Jane | Secrétaire | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 184069960001 | |||||||
| LAWRENCE, Christopher | Secrétaire | Dunelm House 47b The Street NR13 5AA Brundall Norfolk | British | 90712300001 | ||||||
| ORTON, Jeffrey Christopher | Secrétaire | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 185565520001 | |||||||
| THORLEY, Anne | Secrétaire | 51 Mill Lane NR17 2NW Attleborough Norfolk | British | 26486150002 | ||||||
| WARMAN, Paul Jonathan | Secrétaire | The Old Rectory Horsey NR29 4EF Great Yarmouth Norfolk | British | 25255550003 | ||||||
| WARMAN, Paul Jonathan | Secrétaire | The Old Rectory Horsey NR29 4EF Great Yarmouth Norfolk | British | 25255550003 | ||||||
| ZACZKIEWICZ, Stacey | Secrétaire | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 170325190001 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Secrétaire | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
| PRIMARY GROUP SERVICES LIMITED | Secrétaire | 10 King William Street EC4N 7TW London | 107712310001 | |||||||
| ASPROU, Caroline Anna | Administrateur | Highnoon Woodbastwick Road, Blofield Heath NR13 4QH Norwich Norfolk | British | 76073630001 | ||||||
| BELL, Graeme Paul | Administrateur | 6 Moule Rise LS25 2PH Garforth West Yorkshire | England | British | 100163980001 | |||||
| CAMM, Suzanne Mary | Administrateur | The Old Coach House Norwich Road Reepham NR10 4JN Norwich Norfolk | British | 80914120002 | ||||||
| FRANCIS, Timothy John | Administrateur | Farm End Topcroft NR35 2BB Bungay Norfolk | British | 80914650001 | ||||||
| HARNBY, Alastair John | Administrateur | Dene Bank BD16 4AR Bingley 21 West Yorkshire Uk | United Kingdom | British | 172070220002 | |||||
| HUBBARD, Peter John | Administrateur | Sevenleaze Lane Edge GL6 6NL Stroud Huddaknoll House Gloucestershire United Kingdom | England | British | 28375870003 | |||||
| JAMES, Philip William Henry | Administrateur | Hampton Head 9 Peppercorn Lane Southampton Sn 04 Bermuda | England | British | 33901640008 | |||||
| LAIRD, Oliver Walter | Administrateur | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | United Kingdom | British | 233726140001 | |||||
| LAWRENCE, Christopher | Administrateur | Dunelm House 47b The Street NR13 5AA Brundall Norfolk | British | 90712300001 | ||||||
| MARLEY, Nicholas James | Administrateur | 6 The Brambles Woodside SW19 7AY London | United Kingdom | British | 113304050001 | |||||
| MCGUIRE, Elisabeth Mary | Administrateur | 3 Landfall House Springvale PO34 5AN Seaview Isle Of Wight | British | 80914390001 | ||||||
| MEDDES, Kenneth Sydney | Administrateur | Hillside Townhill Bramham LS23 6QD Wetherby | United Kingdom | British | 11486330002 | |||||
| NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir | Administrateur | 1 Pipers Close CH60 9LJ Heswall Merseyside | United Kingdom | British | 85618250001 | |||||
| POSNER, Howard Michael | Administrateur | Stocks Lane HX2 6PR Luddenden Eaves House Halifax | United Kingdom | British | 139631580001 | |||||
| RIVETT, Paul Geoffrey Leo | Administrateur | Westfield Place Whinburgh Road, Westfield NR19 1QJ Dereham Norfolk | British | 67188630001 | ||||||
| ROLFE, Timothy Paul | Administrateur | 9 Overhill CR6 9JR Warlingham Surrey | England | British | 107872640001 | |||||
| SMITH, Paul Kenneth | Administrateur | 4 Merchant Exchange Bridge Street YO1 6LT York North Yorkshire | United Kingdom | British | 126031290001 | |||||
| SMYTH, Timothy John | Administrateur | 2 Knoll Road RH4 3EW Dorking Surrey | United Kingdom | British | 77794000002 | |||||
| THORLEY, Anne | Administrateur | 51 Mill Lane NR17 2NW Attleborough Norfolk | British | 26486150002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk General Insurance Limited | 06 avr. 2016 | Gibraltar Island Road Old Mill Business Park LS10 1RJ Leeds Cast House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TPS (INSURANCE ADMIN SERVICES) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 28 févr. 2007 Livré le 15 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions First fixed charge all shares in any group company,all of its investments now or subsequently belonging to it held by an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge of deposit | Créé le 24 déc. 2004 Livré le 31 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Deposit initially of £50,000 credited to account designation 68126255 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0