AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED

AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAXIS HEALTH & FITNESS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02802122
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED ?

    • Installations de fitness (93130) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de C/O Pure Gym Limited Town Centre House Leeds LS2 8LY United Kingdom à 15 Canada Square London E14 5GL le 28 févr. 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 06 févr. 2018

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Peter William Denby Roberts en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jacques De Bruin en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Notification de L a Fitness Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 août 2017

    2 pagesPSC02

    Cessation de Crown Sports Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 août 2017

    1 pagesPSC07

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 avr. 2016

    État du capital au 12 avr. 2016

    • Capital: GBP 1,144,028
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 oct. 2015 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall Doncaster South Yorkshire DN3 1QR à C/O Pure Gym Limited Town Centre House Leeds LS2 8LY le 06 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 028021220014 en totalité

    4 pagesMR04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter William Denby Roberts le 08 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2014

    8 pagesAA

    Nomination de Mr Adam John Gordon Bellamy en tant que secrétaire le 28 mai 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Ross Steven Chester en tant que directeur le 28 mai 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Martin Long en tant que directeur le 28 mai 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Secrétaire
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    198433720001
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish172693720002
    COBBOLD, Humphrey Michael
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish100141010001
    DAVIES, Raymond Alan
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    Secrétaire
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    British4878250001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    British124301460001
    JARVIS, Diane
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    Secrétaire
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    British79818790001
    STEELE, Ronald Frank
    Middle Halings
    Halings Lane Denham
    UB9 5DQ Uxbridge
    Middlesex
    Secrétaire
    Middle Halings
    Halings Lane Denham
    UB9 5DQ Uxbridge
    Middlesex
    British42597630001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Secrétaire
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    British114849640001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Secrétaire
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    British114849640001
    TAYLOR, Graham
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    Secrétaire
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    British82374420004
    TAYLOR, Richard
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    Secrétaire
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    British71126560002
    ELK COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Corporate House
    419-421 High Road
    HA3 6EL Harrow
    Middlesex
    Secrétaire désigné
    Corporate House
    419-421 High Road
    HA3 6EL Harrow
    Middlesex
    900007410001
    ARGYLE, Coralie
    80 Dene Road
    HA6 2DF Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    80 Dene Road
    HA6 2DF Northwood
    Middlesex
    British49868490002
    BROSTER, Stuart Paul
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    Administrateur
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    United KingdomBritish114847350001
    BRUIN, Jacques De
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomSouth African198346420001
    CHESTER, Ross Steven
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    British137527310001
    COSTARD, David James
    8 West Court
    West Drive
    RG4 6GL Sonning On Thames
    Berkshire
    Administrateur
    8 West Court
    West Drive
    RG4 6GL Sonning On Thames
    Berkshire
    UkEnglish93663310001
    DAVIES, Raymond Alan
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    Administrateur
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    British4878250001
    FLAHIVE, Brendan Joseph
    11 Eastbury Avenue
    HA6 3LB Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    11 Eastbury Avenue
    HA6 3LB Northwood
    Middlesex
    UkBritish24222010001
    GAMBLE, John William
    22 St Judes Road
    TW20 0BY Egham
    Surrey
    Administrateur
    22 St Judes Road
    TW20 0BY Egham
    Surrey
    British40919790001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish124301460001
    GREALEY, Martyn
    Rowington House Pound Close
    Off Poolhead Lane
    B94 5ET Earlswood
    Warwickshire
    Administrateur
    Rowington House Pound Close
    Off Poolhead Lane
    B94 5ET Earlswood
    Warwickshire
    United KingdomBritish125401590001
    JARVIS, Diane
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    Administrateur
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    EnglandBritish79818790001
    LEWIS, Stephen Clifton
    2 Pinewood Close
    SL9 7DS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 Pinewood Close
    SL9 7DS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish34392890004
    LISTER, James Ashton
    11 Norham Road
    OX2 6SF Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    11 Norham Road
    OX2 6SF Oxford
    Oxfordshire
    British2798240004
    LONG, Martin
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish125885350001
    MCCOLL, Arthur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Administrateur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    AustraliaBritish139099550001
    PENNINGTON, Jonathan Michael
    24 Tavistock Terrace
    N19 4DB London
    Administrateur
    24 Tavistock Terrace
    N19 4DB London
    EnglandBritish26455990002
    PHILPOTT, Stephen John Randall
    St John's Cottage
    Cherry Tree Lane
    SL3 6JE Fulmer
    Berkshire
    Administrateur
    St John's Cottage
    Cherry Tree Lane
    SL3 6JE Fulmer
    Berkshire
    United KingdomBritish45243130001
    PINSENT, Stephen
    Two Gables Winchmore Hill
    HP7 0PN Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Two Gables Winchmore Hill
    HP7 0PN Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish56439840001
    PURSLOW, Christian Mark Cecil
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    Administrateur
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    United KingdomBritish83244210001
    ROBERTS, Peter William Denby
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    The Hutts
    United Kingdom
    Administrateur
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    The Hutts
    United Kingdom
    EnglandBritish106538510001
    STEELE, Ronald Frank
    Middle Halings
    Halings Lane Denham
    UB9 5DQ Uxbridge
    Middlesex
    Administrateur
    Middle Halings
    Halings Lane Denham
    UB9 5DQ Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritish42597630001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritish114849640001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Administrateur
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritish114849640001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    01 août 2017
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03224406
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02476401
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 juin 2014
    Livré le 10 juin 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 10 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A supplemental security and confirmation deed
    Créé le 30 août 2011
    Livré le 13 sept. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and all monies due or to become due from the chargors to all or any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its relevant assets as more specifically referred to in the relevant security documents upon the terms contained in the relevant security documents. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Amendment deed
    Créé le 21 juil. 2009
    Livré le 31 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The remaining assets, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Various Lenders (The Security Trustee)
    Transactions
    • 31 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental debenture
    Créé le 21 juin 2006
    Livré le 03 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H burnham squash club 821A yeovil road trading estate slough t/no BK315801 and northwood squash centre chestnut avenue northwood middlesex t/no AGL37538.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 03 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 23 mars 2006
    Livré le 03 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the crunch finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its interest in the land referred to opposite its name in schedule 1 meaning, burnham squash club, 821A yeovil road trading estate, slough t/no BK315801. Northwood squash centre, chestnut avenue, northwood, middlesex. For details o f further land charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 03 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 20 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 23 mars 2006
    Livré le 03 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 03 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 21 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 26 avr. 2002
    Livré le 09 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies,liabilities and obligations whatsoever due or to become due by any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including (I) the f/hold property known as northwood squash club,chestnut ave,northwood,midd'x; AGL37538; (ii) f/hold property known as broke hill golf club,sevenoaks road,halstead sevenoaks; K588424 and K685755; (iii) l/hold property known as broke hill golf club,sevenoaks rd,halstead,sevenoaks; K725693; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transactions
    • 09 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 oct. 2001
    Livré le 19 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 821A yeovil road trading estate slough berkshire t/n-BK315801.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 15 oct. 2001
    Livré le 19 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H chestnut avenue northwood middlesex t/n-AGL37538.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 oct. 2001
    Livré le 17 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 juin 1996
    Livré le 27 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being northwood squash centre chestnut avenue northwood middlesex together with all buildings fixtures and fittings thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 27 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 10 juin 1996
    Livré le 19 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 sept. 1993
    Livré le 23 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 821A yeovil road trading estate slough berkshire with all buildings and fixtures thereon and by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 juin 1993
    Livré le 22 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a burnham squash club building 812A yeovil road trading estate slough bucks and the proceeds of sale thereof assigns the goodwill of the business full benefit of all licences and by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 avr. 2019Dissolved on
    06 févr. 2018Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0