SERVASSURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSERVASSURE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03021117
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SERVASSURE LIMITED ?

    • (6420) /

    Où se situe SERVASSURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Greenway House
    Greenway Business Park
    CM19 5QD Pinnacles, Harlow
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SERVASSURE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STERRY COMMUNICATIONS (UK) LIMITED25 avr. 199525 avr. 1995
    NEMOURE LIMITED13 févr. 199513 févr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de SERVASSURE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour SERVASSURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    10 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Certificat de changement de nom

    Company name changed sterry communications (uk) limit ed\certificate issued on 18/02/08
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages190

    Qui sont les dirigeants de SERVASSURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WEST, Michael David
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    British112844320001
    WEST, Michael David
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    Secrétaire
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    British112844320001
    KEAN, Scott Charles
    39 Lawrence Moorings
    CM21 9PE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    39 Lawrence Moorings
    CM21 9PE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishDirector80444700003
    BULTITUDE, David John, Mr.
    The Old Cottage Bucks Hill
    Watford
    WD4 9AE Kings Langley
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Old Cottage Bucks Hill
    Watford
    WD4 9AE Kings Langley
    Hertfordshire
    British61307690002
    HENWOOD, Julian Richard
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    Secrétaire
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    British65188860002
    POWER, Mark Peter
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    Secrétaire
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    BritishFinancial Controller24900380002
    WILKINSON, Alexander Mcnish
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    Secrétaire
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    BritishCompany Director76710610001
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    BritishCompany Director74738270002
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire désigné
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    BLOOMFIELD, Garry James
    Lower Ridge Farm
    Plucksbridge Road
    SK6 7DY Marple
    Cheshire
    Administrateur
    Lower Ridge Farm
    Plucksbridge Road
    SK6 7DY Marple
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director43196770002
    DICKER, Timothy Stanley
    260 Rayleigh Road
    SS9 5XL Leigh On Sea
    Essex
    Administrateur
    260 Rayleigh Road
    SS9 5XL Leigh On Sea
    Essex
    BritishOperations Director98850820001
    FOX, John Martin
    The Haven
    Carters Lane
    CM22 6AQ Henham
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Haven
    Carters Lane
    CM22 6AQ Henham
    Hertfordshire
    Great BritainBritishSales And Marketing127207050001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector64442870001
    GLOVER, Michael John
    Commerce House
    2-6 Bath Street
    Slough
    Berkshire
    Administrateur
    Commerce House
    2-6 Bath Street
    Slough
    Berkshire
    BritishInvestment Banker2239730001
    KEEVIL, Geoffrey Charles
    65 Shepherds Lane
    HP9 2DU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    65 Shepherds Lane
    HP9 2DU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director19845180001
    TUPMAN, Timothy Alexander
    Highlands
    Berden
    CM23 1AB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Highlands
    Berden
    CM23 1AB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director67184090006
    WILKINSON, Alexander Mcnish
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    Administrateur
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    BritishCompany Director76710610001
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    BritishCompany Director74738270002
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Administrateur désigné
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Administrateur désigné
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001

    SERVASSURE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 24 mars 2000
    Livré le 14 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and all monies and liabilities due or to become due from sterry group limited, sterry holdings limited and the company to the chargee on any account whatsoever in accordance with the terms of the deferred consideration agreement dated on or around 24TH march 2000
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • !Siemens Communications Limited
    Transactions
    • 14 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 22 nov. 1999
    Livré le 02 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 nov. 1999
    Livré le 29 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 mai 1995
    Livré le 11 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 02 mai 1995
    Livré le 11 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of assignment any monies payable to the bank for or in connection with the disposal (by way of sale or otherwise) of any chattels the chattels :-nom code 70182 pd no 08/93 invoice date FEB93 internal ref 210762 invoice VALUE6,270,00 david polland asset description 610MB 498/33. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0