AUTONOMY SYSTEMS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | AUTONOMY SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03063054 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AUTONOMY SYSTEMS LIMITED ?
Adresse du siège social | The Lawn 22-30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury Berkshire England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AUTONOMY SYSTEMS LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour AUTONOMY SYSTEMS LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mai 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 mai 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 mai 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour AUTONOMY SYSTEMS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 30 juin 2023 | 31 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital au 25 mars 2024
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 oct. 2023 au 30 juin 2023 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2022 | 26 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Micro Focus Mhc Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 sept. 2018 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Micro Focus Chc Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 sept. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Notification de Micro Focus Chc Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov. 2017 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Entco Foreign Holdco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov. 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Notification de Entco Foreign Holdco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept. 2017 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Micro Focus International Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 sept. 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rupert Michael Henry Green en tant que directeur le 10 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Candice Tiffany Chisholm en tant que secrétaire le 30 janv. 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Candice Tiffany Chisholm en tant que secrétaire le 20 janv. 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2021 | 29 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Rupert Michael Henry Green en tant qu'administrateur le 30 juin 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jane Caroline Grantham Smithard en tant que directeur le 30 juin 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Howard Norton en tant que directeur le 23 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 oct. 2020 | 28 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Jon Vine en tant qu'administrateur le 23 juin 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de AUTONOMY SYSTEMS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE, Jon | Administrateur | 22-30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | United Kingdom | British | Co Head Of Tax | 284647360001 | ||||
CHISHOLM, Candice Tiffany | Secrétaire | 22-30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | 304500500001 | |||||||
KANTER, Andrew Mark | Secrétaire | New Barn Hill Farm May Street SG8 8SN Great Chishill | American | Legal Counsel | 73002300003 | |||||
LYNCH, Michael Richard, Dr | Secrétaire | 11 Little Lane Melborn SG8 6BU Royston Hertfordshire | British | 68771740001 | ||||||
PUTLAND, Roberto Adriano | Secrétaire | Amen Corner RG12 1HN Bracknell Cain Road Berkshire England | 169627570001 | |||||||
TROWER, Tara | Secrétaire | Cain Road Amen Corner RG12 1HN Bracknell C/O Hewlett-Packard Berkshire England | 193898330001 | |||||||
CLYDE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 51 Eastcheap EC3M 1JP London | 38770650001 | |||||||
MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Black Friars Lane EC4V 6HD London 20 | 39182980001 | |||||||
CASHMAN, Barry Gareth | Administrateur | Amen Corner RG12 1HN Bracknell Cain Road Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Sales Director | 141815860001 | ||||
DUFFY, Christopher William | Administrateur désigné | 7 The Broadwalk HA6 2XD Northwood Middlesex | British | 900005310001 | ||||||
GARRETT, Michael John | Administrateur | Amen Corner RG12 1HN Bracknell Cain Road Berkshire | England | British | Managing Director | 233416010001 | ||||
GAUNT, Richard Gwynne | Administrateur | 107 Seddon House Barbican EC2Y 8BX London | British | Electronics Engineer | 47981910002 | |||||
GREEN, Rupert Michael Henry | Administrateur | 22-30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | England | British | Executive | 297494620001 | ||||
HARTLEY, Christopher John | Administrateur | 34 Wisteria Way NN3 3QB Northampton Northamptonshire | British | Sales Director | 70953090001 | |||||
HUSSAIN, Sushovan Tareque | Administrateur | Cade House 2 Chipstead Lane TN13 2AG Sevenoaks Kent | England | British | Chartered Accountant | 83863260001 | ||||
KANTER, Andrew Mark | Administrateur | New Barn Hill Farm May Street SG8 8SN Great Chishill | United Kingdom | American | Lawyer | 73002300003 | ||||
LETELIER, Sergio Erik | Administrateur | Amen Corner RG12 1HN Bracknell Cain Road Berkshire England | France | French | Lawyer | 132467640015 | ||||
LYNCH, Michael Richard, Dr | Administrateur | 11 Little Lane Melborn SG8 6BU Royston Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 68771740001 | ||||
MORRIS, Simon Edward | Administrateur | 44 Wolseley Gardens Grove Park W4 3LS Chiswick London | British | Marketing Director | 54746360002 | |||||
NORTON, Graham Howard | Administrateur | 22-30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | United Kingdom | British | Director | 149360780007 | ||||
PAGE, David William | Administrateur désigné | Chafford House Camden Park TN2 5AD Tunbridge Wells Kent | British | 900005300001 | ||||||
PUTLAND, Roberto Adriano | Administrateur | Autonomy Cambridge Business Park Cambridge Cambridgeshirecb4 0wz | England | British | Lawyer | 162794370001 | ||||
SANDERS, Julian | Administrateur | Woodlands 7 De Beche Close CB3 8UP Papworth Everard Cambridgeshire | England | British | Accountant | 182327030002 | ||||
SCOTT, Joel | Administrateur | Autonomy Cambridge Business Park Cambridge Cambridgeshirecb4 0wz | Usa | Canadian | General Counsel | 170481320001 | ||||
SMITHARD, Jane Caroline Grantham | Administrateur | 22-30 Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire England | United Kingdom | British | Director | 208035540001 | ||||
TROWER, Tara Dawn | Administrateur | Amen Corner RG12 1HN Bracknell Cain Road Berkshire | England | British | Lawyer | 134963980001 | ||||
WILSON, Nicholas Anthony | Administrateur | Autonomy Cambridge Business Park Cambridge Cambridgeshirecb4 0wz | United Kingdom | British | Managing Director | 137369560001 | ||||
YELLAND, Christopher Henry | Administrateur | Amen Corner RG12 1HN Bracknell Cain Road Berkshire England | United Kingdom | British | Accountant | 170468310001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AUTONOMY SYSTEMS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro Focus Mhc Limited | 19 sept. 2018 | Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn, 22-30 Berkshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Micro Focus Chc Limited | 01 nov. 2017 | Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn, 22-30 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Entco Foreign Holdco Limited | 01 sept. 2017 | Cain Road RG12 1HN Bracknell Amen Corner Berkshire England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Micro Focus International Plc | 01 sept. 2017 | Old Bath Road RG14 1QN Newbury The Lawn Berkshire United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Hewlett Packard Enterprise Company | 06 avr. 2016 | Orange Street Wilmington DE19801 New Castle 120 Delaware United States | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0