STUDENTPACKS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | STUDENTPACKS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03071156 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STUDENTPACKS LIMITED ?
Adresse du siège social | 140 Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon Oxfordshire England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STUDENTPACKS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 nov. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour STUDENTPACKS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian John Webb en tant que directeur le 11 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gregory Davidson-Shrine le 05 sept. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des détails de Hammond Bridge Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 juin 2017 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Nomination de Mr Gregory Davidson-Shrine en tant que secrétaire le 30 juin 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Craig Lewendon en tant qu'administrateur le 30 juin 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Neil Thomas George Martin en tant qu'administrateur le 30 juin 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Wilson en tant qu'administrateur le 30 juin 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Gregory Davidson-Shrine en tant qu'administrateur le 30 juin 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Glenn Peter Leech en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Gregory Bauernfeind en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Richard Cashmore en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Michael Bunting en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart Steven Marriner en tant que secrétaire le 30 juin 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 août 2017 au 30 nov. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Rowan House Cherry Orchard North Kembrey Park Swindon SN2 8UH à 140 Eastern Avenue Milton Park, Milton Abingdon Oxfordshire OX14 4SB le 03 juil. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 déc. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas John Gresham en tant que directeur le 01 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Gregory Bauernfeind en tant qu'administrateur le 01 oct. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de STUDENTPACKS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVIDSON-SHRINE, Gregory | Secrétaire | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | 234785990001 | |||||||
DAVIDSON-SHRINE, Gregory | Administrateur | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Company Director | 169072790002 | ||||
LEWENDON, Craig Stuart | Administrateur | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Company Director | 234768920001 | ||||
MARTIN, Neil Thomas George | Administrateur | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | United Kingdom | British | Company Director | 126681070006 | ||||
WILSON, Andrew | Administrateur | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Company Director | 69047320004 | ||||
ELSEY, Robert David | Secrétaire | 7 Ravenscroft Gardens BA14 7JU Trowbridge Wiltshire | British | Company Director | 44433580001 | |||||
GAHAN, Michael William | Secrétaire | The Orchard Vinegar Hill NP26 3EJ Undy Gwent | British | Finance Director | 182707860001 | |||||
JARRETT, Susan Lynne | Secrétaire | 37 Bobbin Lane Westwood BA15 2DL Bradford On Avon Wiltshire | British | Finance Dir | 54448350001 | |||||
MARRINER, Stuart Steven | Secrétaire | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | 168621290001 | |||||||
STAFFORD, Robert Simeon | Secrétaire | 4 Clifton Wood Crescent Clifton Wood BS8 4TU Bristol | British | Finance Director | 77214360002 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BARNETT, Melanie Suzanne | Administrateur | Old Meadows Farm Fowlswick Lane, Allington SN14 6LT Chippenham Wiltshire | England | British | Chief Executive | 116719600002 | ||||
BAUERNFEIND, David Gregory | Administrateur | Cherry Orchard North Kembrey Park SN2 8UH Swindon Rowan House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 99529910002 | ||||
BUNTING, Jonathan Michael | Administrateur | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Director | 115232260002 | ||||
CASHMORE, Mark Richard | Administrateur | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Director | 115657470004 | ||||
ELSEY, Robert David | Administrateur | 7 Ravenscroft Gardens BA14 7JU Trowbridge Wiltshire | United Kingdom | British | Company Director | 44433580001 | ||||
GAHAN, Michael William | Administrateur | The Orchard Vinegar Hill NP26 3EJ Undy Gwent | United Kingdom | British | Finance Director | 182707860001 | ||||
GEORGE, Dudley Robert Charles | Administrateur | School Cottage Coaley GL11 5ED Dursley Gloucestershire | British | Company Director | 44433600001 | |||||
GOULD, Jeffrey Richard | Administrateur | 4 Hobbs Hill Keevil BA14 6LR Trowbridge Wiltshire | British | Director | 45469620001 | |||||
GRESHAM, Nicholas John | Administrateur | Cherry Orchard North Kembrey Park SN2 8UH Swindon Rowan House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 91773790002 | ||||
HUBBARD, Christopher John | Administrateur | 33 Walmsley Chase Hilperton BA14 7HY Trowbridge Wiltshire | British | Business Development Manager | 90752140001 | |||||
LEECH, Glenn Peter | Administrateur | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | United Kingdom | British | Managing Director | 131999190002 | ||||
RESTORICK, Steven William | Administrateur | 4 Church Lane Rode BA11 6PN Frome Somerset Ba11 6pn | British | Sales Coordinator | 90752190001 | |||||
STAFFORD, Robert Simeon | Administrateur | 4 Clifton Wood Crescent Clifton Wood BS8 4TU Bristol | England | British | Finance Director | 77214360002 | ||||
WEBB, Ian John | Administrateur | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 Oxfordshire England | England | British | Accountant | 134286210001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STUDENTPACKS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammond Bridge Limited | 06 avr. 2016 | Eastern Avenue Milton Park, Milton OX14 4SB Abingdon 140 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0