THE DEVON DAIRY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE DEVON DAIRY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03414586
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE DEVON DAIRY LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe THE DEVON DAIRY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Tern Valley Business Park Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE DEVON DAIRY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PENINSULA MILK PROCESSORS LIMITED05 août 199705 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de THE DEVON DAIRY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour THE DEVON DAIRY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher Ronald Thornton en tant que directeur le 30 août 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Steven Paul Hodkinson en tant qu'administrateur le 30 août 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Major Singh Rana en tant qu'administrateur le 30 août 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 05 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Lee Greenbury en tant que directeur le 18 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Christopher Ronald Thornton en tant qu'administrateur le 13 nov. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Ronald Mcinnes en tant que directeur le 01 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Lee Greenbury en tant qu'administrateur le 12 juin 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ronald Klaas Otto Kers en tant que directeur le 30 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Maureen Agnes Burnside en tant que secrétaire le 31 mai 2017

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 août 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 août 2015

    État du capital au 14 août 2015

    • Capital: GBP 366,039
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de THE DEVON DAIRY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HODKINSON, Steven Paul
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Administrateur
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish217572630001
    RANA, Major Singh
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Administrateur
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish165428070001
    BURNSIDE, Maureen Agnes
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    Secrétaire
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    153975620001
    DAVIDSON, Allison Jane
    11 Teign Village Hennock
    Bovey Tracey
    TQ13 9QJ Newton Abbot
    Devon
    Secrétaire
    11 Teign Village Hennock
    Bovey Tracey
    TQ13 9QJ Newton Abbot
    Devon
    British84272680001
    KITTOW, Allison Jane
    11 Teign Village
    Hennock
    TQ13 9QJ Bovey Tracey
    Devon
    Secrétaire
    11 Teign Village
    Hennock
    TQ13 9QJ Bovey Tracey
    Devon
    British84082280001
    LAWRENCE, Geoffrey Owen
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    Secrétaire
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    British46842010001
    OPENSHAW, Sally Jane
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    Secrétaire
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    British54072560001
    REED, Lyndsay Anne
    19 Hawthorn Road
    Bishopsmead
    PL19 9DL Tavistock
    Devon
    Secrétaire
    19 Hawthorn Road
    Bishopsmead
    PL19 9DL Tavistock
    Devon
    British46842100001
    SWEENEY, Gerard
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    Secrétaire
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    British80242320001
    YOUNG, Karen Bridget
    3 Wild Orchard
    BA3 5XJ Faulkland
    Somerset
    Secrétaire
    3 Wild Orchard
    BA3 5XJ Faulkland
    Somerset
    British94953930001
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    Oceana House
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    Oceana House
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    59771390005
    BAKER, Peter Monty
    Three Oaks Gulworthy
    PL19 8AX Tavistock
    Devon
    Administrateur
    Three Oaks Gulworthy
    PL19 8AX Tavistock
    Devon
    British43634310001
    BENNETT, Alan
    Pengelly
    Hewas Water
    PL26 7JG St Austell
    Cornwall
    Administrateur
    Pengelly
    Hewas Water
    PL26 7JG St Austell
    Cornwall
    British71925150001
    BLADES, Laurence William
    Hurlditch Farm Lamerton
    PL19 8QA Tavistock
    Devon
    Administrateur
    Hurlditch Farm Lamerton
    PL19 8QA Tavistock
    Devon
    British52674990001
    BURROW, Richard
    Rill Farm
    East Hill
    EX11 1QH Ottery St. Mary
    Devon
    Administrateur
    Rill Farm
    East Hill
    EX11 1QH Ottery St. Mary
    Devon
    British71924930001
    DE BOER, Athe
    Lower Woodley
    PL30 5JN Bodmin
    Cornwall
    Administrateur
    Lower Woodley
    PL30 5JN Bodmin
    Cornwall
    Dutch43634210001
    GREENBURY, Lee
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Administrateur
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish61478920003
    KEANE, William Gerard
    33 Burnhead Road
    G43 2SU Glasgow
    Administrateur
    33 Burnhead Road
    G43 2SU Glasgow
    ScotlandBritish33614620001
    KERS, Ronald Klaas Otto
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    Administrateur
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    EnglandDutch165776800001
    KIDSON, Graham Leonard Patrick
    Teign Gorge House
    Sandy Park, Chagford
    TQ13 8JW Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Teign Gorge House
    Sandy Park, Chagford
    TQ13 8JW Newton Abbot
    Devon
    British63723090002
    LAMDEN, David
    Antony Pedigree Farms
    West Antony
    PL11 3AB Torpoint
    Cornwall
    Administrateur
    Antony Pedigree Farms
    West Antony
    PL11 3AB Torpoint
    Cornwall
    British54820180002
    LAWRENCE, Geoffrey Owen
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    Administrateur
    Bellamy Cottage
    Chawleigh
    EX18 7HR Chulmleigh
    Devon
    British46842010001
    LOUD, Sandra Gladys
    Northdown
    Lewdown
    EX20 4EB Okehampton
    Devon
    Administrateur
    Northdown
    Lewdown
    EX20 4EB Okehampton
    Devon
    British54819870001
    MCINNES, Andrew Ronald
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    Administrateur
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    England
    ScotlandBritish174315690001
    NICHOLLS, Barry John Leonard
    Stocks Farm House
    The Stocks, Seend
    SN12 6PL Melksham
    Wiltshire
    Administrateur
    Stocks Farm House
    The Stocks, Seend
    SN12 6PL Melksham
    Wiltshire
    EnglandBritish71018890006
    OPENSHAW, Nicholas Henry Folliott
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    Administrateur
    Northdown House
    Northdown Road
    EX39 3LT Bideford
    Devon
    United KingdomBritish44347590002
    OVENS, Jeremy
    Brendon Farm
    Halwill
    EX21 5UH Beaworthy
    Devon
    Administrateur
    Brendon Farm
    Halwill
    EX21 5UH Beaworthy
    Devon
    British65850270001
    PARISH, David Edmund
    Weir Mill Farm
    Willand
    EX15 2RE Cullompton
    Devon
    England
    Administrateur
    Weir Mill Farm
    Willand
    EX15 2RE Cullompton
    Devon
    England
    EnglandBritish34592070001
    POCOCK, Brian Walter
    Pennance Vean Farm
    Prosser Hill Gwithian
    TR27 5EB Hayle
    Cornwall
    Administrateur
    Pennance Vean Farm
    Prosser Hill Gwithian
    TR27 5EB Hayle
    Cornwall
    EnglandBritish84082420001
    RICHARDS, David Maldwyn
    Ash Grove
    BA5 2LX Wells
    4
    Somerset
    United Kingdom
    Administrateur
    Ash Grove
    BA5 2LX Wells
    4
    Somerset
    United Kingdom
    United KingdomBritish119384920003
    SWEENEY, Gerard
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    Administrateur
    21 Braidholm Road
    Giffnock
    G46 6HS Glasgow
    United KingdomBritish80242320001
    THORNTON, Christopher Ronald
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    Administrateur
    Shrewsbury Road
    Market Drayton
    TF9 3SQ Shropshire
    Tern Valley Business Park
    EnglandBritish233720830001
    VENNING, Gerald William
    Lower Birch Farm
    Bere Alston
    PL20 7BY Yelverton
    Devon
    Administrateur
    Lower Birch Farm
    Bere Alston
    PL20 7BY Yelverton
    Devon
    British43634420001
    WILLIAMS, David Anthony James
    71a Long Ashton Road
    Long Ashton
    BS41 9HW Bristol
    Administrateur
    71a Long Ashton Road
    Long Ashton
    BS41 9HW Bristol
    EnglandBritish57267910003
    WISEMAN, Robert Tennant
    Auchterarder House
    PH3 1DZ Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Auchterarder House
    PH3 1DZ Auchterarder
    Perthshire
    United KingdomBritish3813060003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE DEVON DAIRY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Müller Wiseman Dairies Limited
    Glasgow Road
    East Kilbride
    G74 4PA Glasgow
    159
    Scotland
    06 avr. 2016
    Glasgow Road
    East Kilbride
    G74 4PA Glasgow
    159
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueCompany
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementScotland
    Numéro d'enregistrementSc146494
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    THE DEVON DAIRY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    An omnibus guarantee and set off agreement
    Créé le 20 févr. 2006
    Livré le 23 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 20 févr. 2006
    Livré le 23 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All plant and machinery vehicles computers and other equipment being two vertical stainless steel raw milk intake tanks capacity: 11,000 litres, two vertical jacketed raw milk intake tanks capacity: 45,000 litres and three vertical jacketed storage tanks capacity: 45,000 litres for details of further chattels charged please refer to form 395, and all spare parts replacements modifications and additions thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 23 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 févr. 2006
    Livré le 23 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H properties k/a land being peninsula milk processing factory, hameldown road, okehampton t/n DN412666. Beardown road, exter road industrial estate, okehampton t/n DN480942 and l/h land being land at beardown road, exter road industrial estate, okehampton t/n DN480943, and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery, all moneys under contracts or policies of insurance relating to the property and the rents, profits, income fees and other sums payable. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 23 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 26 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 20 févr. 2006
    Livré le 23 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 23 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 févr. 2006
    Livré le 23 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 15 oct. 2004
    Livré le 22 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of the chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property k/a peninsula milk processing factory,hameldown road,okehampton,t/no's DN412666 and DN480942(f/h) and DN480943(l/h). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerleenbank B.a as Security Trustee
    Transactions
    • 22 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 sept. 2002
    Livré le 05 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 05 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 sept. 2002
    Livré le 02 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a peninsula milk processing factory, hameldown road, exeter, devon EX20 1UB t/no. DN412666 as continuing security for the payment of the mortgagee of all monies covenanted to be paid by the mortgagor and/or due to the mortgagee hereunder.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 sept. 2002
    Livré le 02 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 sept. 2002
    Livré le 02 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a peninsula milk processing facory, hameldown road, exeter, devon EX20 1UB. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 15 déc. 1999
    Livré le 24 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement dated (as therein defined) or otherwise
    Brèves mentions
    Fixed charge all specified debts being any book debts (purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement) the ownership of which fail to vest in the chargee for any reason together with the related rights pertaining to such book debts, all other debts being all amounts of indebtedness now or at any time owing to the company on any account whatsoever (together with the related rights) other than specified debts, floating charge such moneys which the company may receive in respect of the other debts.
    Personnes ayant droit
    • First National Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 24 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1999
    Livré le 02 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land situate at the exeter road industrial estate okehampton in the county of devon.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed & floating charge
    Créé le 08 mars 1999
    Livré le 10 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All debts and their related rights purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement which fail to vest absolutely and effectively in the security holder (for any reason) by way of floating charge all undertqaking and the property rights and assets of the company including stock in trade and uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 10 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 mars 1998
    Livré le 27 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0