WATKINS HIRE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWATKINS HIRE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03599314
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WATKINS HIRE LIMITED ?

    • Location et location d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77390) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe WATKINS HIRE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Building
    20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WATKINS HIRE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour WATKINS HIRE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Birmingham B3 3HN à C/O Teneo Financial Advisory Limited the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT le 09 juin 2023

    2 pagesAD01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Toshiba Carrier Uk Ltd Elite House Guildford Road Fetcham Surrey KT22 9UT

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Toshiba Carrier Uk Ltd Elite House Guildford Road Fetcham Surrey KT22 9UT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Porsham Close Belliver Industrial Estate Plymouth Devon PL6 7DB England à C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Birmingham B3 3HN le 08 août 2022

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 juil. 2022

    LRESSP

    Modification des détails de Carrier Rental Systems (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 mai 2018

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 23 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Justin Paddock en tant que directeur le 14 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alexandra Elizabeth Gooch en tant que directeur le 14 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Steven Blaby en tant que directeur le 14 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Anthony Robinson en tant qu'administrateur le 14 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Neil Andrew Vincent Gregor Macgregor en tant qu'administrateur le 14 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Simon Ross Harden Mcmullen en tant que directeur le 16 août 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Miss Alexandra Elizabeth Gooch en tant qu'administrateur le 16 août 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Andrew Justin Paddock en tant qu'administrateur le 04 janv. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Archibald Ziwanemoyo Hungwe en tant que directeur le 04 janv. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de WATKINS HIRE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BONIFACE, Simon
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Techologies House
    England
    Secrétaire
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Techologies House
    England
    250231460001
    GREGOR MACGREGOR, Neil Andrew Vincent
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    1st Floor, Ash House
    England
    Administrateur
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    1st Floor, Ash House
    England
    United KingdomBritishDirector286329300001
    ROBINSON, John Anthony
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    1st Floor, Ash House
    England
    Administrateur
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    1st Floor, Ash House
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant205997980001
    BLABY, Steven
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Secrétaire
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    British153931730001
    BOWER, Stephen Andrew
    21 Alverton Drive
    Bishops Cleeve
    GL52 4TD Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    21 Alverton Drive
    Bishops Cleeve
    GL52 4TD Cheltenham
    Gloucestershire
    British46665380002
    SLOSS, Robert
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    Oak House
    England
    Secrétaire
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    Oak House
    England
    218720440001
    WATKINS, Tonia
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Ward Industrial Estate
    Gloucestershire
    England
    Secrétaire
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Ward Industrial Estate
    Gloucestershire
    England
    British65091270001
    WAYNE, Harold
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    Secrétaire désigné
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    British900005490001
    WILCOCK, Laura Jayne
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    Oak House
    England
    Secrétaire
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    Oak House
    England
    218720470001
    BLABY, Steven James
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Ltd
    England
    Administrateur
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Ltd
    England
    EnglandEnglishAccountant250616320001
    BLABY, Steven James
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Administrateur
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    UkBritishAccountant80801660002
    BOOTH, Allan George
    Church Road
    Ward Industrial Estate
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Limited
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Church Road
    Ward Industrial Estate
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Limited
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Great BritainBritishBusiness Consultant156989400001
    DREW, Simon John
    Stable Cottage
    HR2 8EG Wormelow
    Herefordshire
    Administrateur
    Stable Cottage
    HR2 8EG Wormelow
    Herefordshire
    EnglandBritishEngineer72486790003
    GOOCH, Alexandra Elizabeth
    Belliver Industrial Estate
    PL6 7DB Plymouth
    Porsham Close
    Devon
    England
    Administrateur
    Belliver Industrial Estate
    PL6 7DB Plymouth
    Porsham Close
    Devon
    England
    EnglandBritishFinance Director286825110001
    HILLS, Mark Edward
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Ward Industrial Estate
    Gloucestershire
    England
    Administrateur
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Ward Industrial Estate
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritishDirector73804920002
    HUNGWE, Archibald Ziwanemoyo
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    England
    Administrateur
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    England
    EnglandBritishGeneral Manager240353160001
    JONES, Richard Hilton
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    England
    Administrateur
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    England
    EnglandBritishGeneral Manager101090610001
    LODDMER, Rogel Samuel
    Church Road
    Ward Industrial Estate
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Limited
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Church Road
    Ward Industrial Estate
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Limited
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant156989570001
    MCDONALD, Steven Thomas
    Porsham Close
    Roborough
    PL6 7DB Plymouth
    Toshiba Carrier
    England
    Administrateur
    Porsham Close
    Roborough
    PL6 7DB Plymouth
    Toshiba Carrier
    England
    EnglandBritishFinance Director133653510001
    MCMULLEN, Simon Ross Harden
    Stockley Close
    UB7 9BL West Drayton
    365
    England
    Administrateur
    Stockley Close
    UB7 9BL West Drayton
    365
    England
    EnglandBritishFinancial Director132089160001
    O'KELLY, Paul Brian
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Administrateur
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    United KingdomBritishNone184075280001
    PADDOCK, Andrew Justin
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    England
    Administrateur
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    England
    EnglandBritishDirector246915550001
    PLATT, Steven Edwin
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Administrateur
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    UkBritishNone184076670001
    STEVENS-SMITH, Terry Victor
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Administrateur
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    UkBritishNone184076550001
    WALTON, Mark Ashley
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Administrateur
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    United KingdomBritishSales Engineer119810660001
    WATKINS, Philip Baden
    Flaxley Abbey
    GL14 1JR Flaxley
    Gloucestershire
    Administrateur
    Flaxley Abbey
    GL14 1JR Flaxley
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector59983980001
    WAYNE, Yvonne
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish900005480001
    WILLIAMS, Roderick Stanley
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Administrateur
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    United KingdomBritishEngineer43026110001
    WRIGHT, Paul Richard
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Carrier Rental Systems, Unit B
    England
    Administrateur
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Carrier Rental Systems, Unit B
    England
    United KingdomBritishFinance Director130318350001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WATKINS HIRE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    21 mai 2018
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03807755
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Ward Industrial Estate
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Temperature Control House
    Gloucestershire
    England
    06 avr. 2016
    Ward Industrial Estate
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Temperature Control House
    Gloucestershire
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement08764183
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    WATKINS HIRE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 mai 2016
    Livré le 05 mai 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 05 mai 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 19 sept. 2013
    Livré le 02 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aldermore Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Chattel mortgage
    Créé le 01 nov. 2012
    Livré le 09 nov. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chattels and the documents. 4400-Lb/hr 200PSI trailerised steam boiler s/no.8769/FWT24. *Scrap container* 6000-lb/hr 150 psi containerised steam 5753. 9920--lb/hr 150PSI trailerised steam boiler s/no.8407. For further details of chattels charged please refer to form MG01, the benefit of all contracts and arrangements, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aldermore Bank PLC
    Transactions
    • 09 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 nov. 2012
    Livré le 08 nov. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aldermore Bank PLC
    Transactions
    • 08 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental chattel mortgage
    Créé le 19 oct. 2012
    Livré le 24 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the non-vesting assets together with the benefit of all existing guarantees warranties and servicing and maintenance agreements and intellectual property rights licensed to or to which the company is entitled in relation to the assets being scania 480R 6X2 tractor cab reg no BX07 nzn see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • State Securities PLC
    Transactions
    • 24 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal assignment of contract monies
    Créé le 28 nov. 2011
    Livré le 29 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any credit balance together with any interests, costs & discounting allowances.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD, Hsbc Asset Finance (UK) LTD Both Together Hsbc
    Transactions
    • 29 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental chattel mortgage
    Créé le 26 août 2011
    Livré le 01 sept. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest in the non-vesting assets being make: zv counter balance forklift s/n zv 120-06-02066, model: zv 120-06 yom: 2003, make: ford transit vrm: Y4 whl model: t 360 double CAB C/n: WF0CXXGBFC2S38767 and make: olympian s/n: OLY00000LC6A00223 model: gep 500-2 cat generator yom: 2007 (for details of further chattels charged please refer to form MG01) together with all guarantees, warranties, and servicing and maintenance agreements see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • State Securities PLC
    Transactions
    • 01 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal assignment
    Créé le 08 mars 2011
    Livré le 22 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 01 févr. 2011
    Livré le 03 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder & the company including the associated rights relating thereto, which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 03 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge (all assets)
    Créé le 01 févr. 2011
    Livré le 03 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 03 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattel mortgage
    Créé le 16 déc. 2010
    Livré le 21 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Trailerised steam boiler serial no GX4000E4471/2,2020,BT3088,containerised steam boiler 25/9496,7372,434005,steam boiler c/w ici caladaie AX300 serial no 35424.5,0503759,1-234CE00 (for further details of chattels charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Chattel mortgage
    Créé le 06 août 2010
    Livré le 12 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Linton services MBR250 used 1149-09-209 2009 boiler house,linton services MBR250 used 1150-09-209 2009 boiler house,linton services MBR250 used 1160-10-209 2009 boiler house,(for further details of chattels charged please refer to form MG01).
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 12 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Long term licence to sub-let
    Créé le 02 juin 2010
    Livré le 03 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The full benefit of the sub-letting agreements and the benefit of all guarantees, indemnities, negotiable instruments and securities.
    Personnes ayant droit
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transactions
    • 03 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 avr. 2010
    Livré le 15 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited & Hsbc Asset Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 15 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 04 févr. 2010
    Livré le 11 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The equipment being 30/60 kw air handlings units x 20 serial no AB37189D0103 to 122 inclusive, 4 stainless steel buffer tanks serial no BT001 BT002 BT005 BT006, 22 kw hotboy boilers x 30 serial no V0509-21 to V0509-50 inclusive, for details of chattels charged, please refer to form MG01, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Watkins Engineering Directors Pension Scheme
    Transactions
    • 11 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 29 janv. 2010
    Livré le 03 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Centric Spv 1 Limited
    Transactions
    • 03 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 25 janv. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 27 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Account assignment
    Créé le 18 déc. 2009
    Livré le 24 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right to all moneys credited to the account number 123659, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Leasing Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 30 sept. 2008
    Livré le 10 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £19,476 and all other monies due or to become due from the company to the chargee due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The deposit account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Pirrie and James Pirrie
    Transactions
    • 10 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Chattel mortgage
    Créé le 02 août 2007
    Livré le 15 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    B10000C containerised hphw boiler N1160/91272,B10002C containerised hphw boiler N1162,B10003C containerised hphw boiler N1163 (for details of further chattels charged please refer to form 395).
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 15 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 02 août 2007
    Livré le 08 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    As per attached schedule of chattels.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 08 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattels mortgage
    Créé le 19 sept. 2003
    Livré le 20 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things being 14 portable boiler plants s/no's N1166 B10006C 91273, N1195 B10030C 91287, N1168 B10008C 91270, or any part thereof, for details of further chattels charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 20 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 25 mai 2003
    Livré le 13 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 mars 2003
    Livré le 19 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 19 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 16 janv. 2003
    Livré le 23 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from welco limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Details of charged account: barclays bank PLC re watkins hire limited current account account number 80157465. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Master agreement and charge
    Créé le 07 janv. 2003
    Livré le 17 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any agreement made whether before on or after the date of the charge between the customer and any person to whom the customer lets or agrees to let the goods on hire.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Assetfinance Limited and (The Finance Company) Acting as Principal or as Agent as Specified Inthe Schedule
    Transactions
    • 17 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    WATKINS HIRE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 juil. 2022Commencement of winding up
    12 nov. 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Harvey Dean
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    practitioner
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Stephen Roland Browne
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    practitioner
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0