KINGSPAN PROPERTY LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | KINGSPAN PROPERTY LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03620695 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?
Adresse du siège social | Greenfield Business Park No 2 Greenfield CH8 7HU Holywell Flintshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Francis Treanor en tant que directeur le 12 déc. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Charles Wilson en tant que directeur le 12 déc. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2012 | 7 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Charles Wilson le 01 janv. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 9 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2010 | 9 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dermot Mulvihill en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Pat Freeman en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Geoff Doherty en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Peter Wilson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de John Treanor en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed banro holdings LIMITED\certificate issued on 07/03/11 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Gilbert Mccarthy en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Gilbert Mccarthy en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 13 pages | AA | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGSPAN GROUP LIMITED | Secrétaire | Greenfield Business Park No 2 Bagillt Road, Greenfield CH8 7GJ Holywell | 107980110001 | |||||||
DOHERTY, Geoff Patrick | Administrateur | Castleknock Golf Club Porterstown Road Castleknock 11 Somerton Dublin 15 Ireland | Ireland | Irish | Finance Director | 161069960001 | ||||
FREEMAN, Pat | Administrateur | Camaghy Hill Magheracloone, Carrickmacross Co. Monaghan Camaghy Hill Ireland | Ireland | Irish | Company Director | 159006020001 | ||||
MURTAGH, Gene | Administrateur | Ballybarrack House Ardee Road IRISH Dundalk Co. Louth Ireland | Ireland | Irish | Company Director | 66920570002 | ||||
DAWSON, Helen | Secrétaire | 6 Welford Road Chapel Brampton NN6 8AF Northampton Northamptonshire | British | 86219590001 | ||||||
EVANS, Martyn William | Secrétaire | 16 Paskin Close Fradley WS13 8NZ Lichfield Staffordshire | English | Director | 78019510001 | |||||
ZANT BOER, Ian | Secrétaire | Grange Meadow Duncote NN12 8AH Towcester Northamptonshire | British | 80009300001 | ||||||
ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||
AUSTEN, Patrick George | Administrateur | 15 Lakeside Drive KT10 9EZ Esher Surrey | United Kingdom | British | Director | 55015730002 | ||||
BARNES, Graham Leslie | Administrateur | 104 Tressillian Road Brockley SE4 1XX London | Uk | British | Director | 14145910002 | ||||
EVANS, John Russell | Administrateur | 5 Wyndham Wood Close Fradley WS13 8UZ Lichfield Staffordshire | British | Engineer | 46914950003 | |||||
EVANS, Jonathan Leslie, Dr | Administrateur | Covert View Cross Hayes Maker Lane DE13 8QR Hoar Cross Staffordshire | British | Engineer | 42254810004 | |||||
EVANS, Martyn William | Administrateur | 16 Paskin Close Fradley WS13 8NZ Lichfield Staffordshire | England | English | Director | 78019510001 | ||||
FELL, Nigel Anthony Russell | Administrateur | Low Hall Pavilion Hackness Road Scalby YO13 0QY Scarborough North Yorkshire | England | British | Director | 73837700002 | ||||
MCCARTHY, Gilbert | Administrateur | Forrest Haven Cabra, Kingscourt Co. Cavan Forrest Haven Ireland | Ireland | Irish | Director | 155528060001 | ||||
MULVIHILL, Dermot | Administrateur | Cloverhill Balrath Road Kells Meath Ireland | Ireland | Irish | Company Director | 145024250001 | ||||
MURTAGH, Brendan | Administrateur | Dunheeda IRISH Kingscourt Co.Cavan Ireland | Irish | Director | 30924190002 | |||||
O'SULLIVAN, Patrick | Administrateur | Carragoona, IRISH Bray Road Co. Dublin Ireland | Irish | Company Director | 116309670001 | |||||
RIDGEWELL, Brian John, Dr | Administrateur | Lower Barn Fields Road Chedworth GL54 4NJ Cheltenham Gloucestershire | British | British | Management Consultant | 52685140001 | ||||
SKIVINGTON, John | Administrateur | 25 Sandfield Terrace GU1 4LN Guildford Surrey | British | Marketing/Sales Director | 66957410001 | |||||
TIPPETT, Richard William | Administrateur | 11 Cranleigh Gardens BS9 1HD Stoke Bishop Bristol | British Australian | Director | 97578070001 | |||||
TREANOR, John Francis | Administrateur | Orchard Cottage Whyle Lane, Brockmanton HR6 0RQ Leominster Orchard Cottage England | England | British | Accountant | 71980650001 | ||||
WILSON, Peter Charles | Administrateur | Southbank Close 22 Southbank Close HR1 2TQ Hereford 22 Herefordshire England | England | Irish | Company Director | 20983740023 | ||||
WOODLOCK, Henry | Administrateur | 14 Selborne Road Handsworth B20 2DW Birmingham | United Kingdom | British | Structural Engineer | 95966360002 | ||||
WRIGHT, David | Administrateur | 49 Avenue Road LE65 2FA Ashby De La Zouch Leicestershire | British | Director | 107062350001 | |||||
ZANT BOER, Ian | Administrateur | Grange Meadow Duncote NN12 8AH Towcester Northamptonshire | British | Solicitor | 80009300001 | |||||
ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 |
KINGSPAN PROPERTY LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 11 mars 2003 Livré le 18 mars 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings and the junction of bridgeman street and pleck road walsall west midlands title number WM236754. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 28 janv. 2003 Livré le 29 janv. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 31 août 2000 Livré le 02 sept. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a manor works pleck road walsall west midlands. T/no. SF108556 & WM236754. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 29 août 2000 Livré le 01 sept. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0