KINGSPAN PROPERTY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKINGSPAN PROPERTY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03620695
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Greenfield Business Park No 2
    Greenfield
    CH8 7HU Holywell
    Flintshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BANRO HOLDINGS LIMITED11 mai 200411 mai 2004
    RENAISSANCE CONSTRUCTION SYSTEMS LIMITED04 févr. 200304 févr. 2003
    BANRO HOLDINGS LIMITED05 mai 199905 mai 1999
    QUEENSWOOD 112 LIMITED24 août 199824 août 1998

    Quels sont les derniers comptes de KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de John Francis Treanor en tant que directeur le 12 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Charles Wilson en tant que directeur le 12 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 déc. 2014

    État du capital au 02 déc. 2014

    • Capital: GBP 13,306.2
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Charles Wilson le 01 janv. 2013

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2010

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de Dermot Mulvihill en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Pat Freeman en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Geoff Doherty en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Peter Wilson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de John Treanor en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed banro holdings LIMITED\certificate issued on 07/03/11
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name07 mars 2011

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de Gilbert Mccarthy en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mr Gilbert Mccarthy en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de KINGSPAN PROPERTY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KINGSPAN GROUP LIMITED
    Greenfield Business Park No 2
    Bagillt Road, Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    Secrétaire
    Greenfield Business Park No 2
    Bagillt Road, Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    107980110001
    DOHERTY, Geoff Patrick
    Castleknock Golf Club
    Porterstown Road
    Castleknock
    11 Somerton
    Dublin 15
    Ireland
    Administrateur
    Castleknock Golf Club
    Porterstown Road
    Castleknock
    11 Somerton
    Dublin 15
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director161069960001
    FREEMAN, Pat
    Camaghy Hill
    Magheracloone, Carrickmacross
    Co. Monaghan
    Camaghy Hill
    Ireland
    Administrateur
    Camaghy Hill
    Magheracloone, Carrickmacross
    Co. Monaghan
    Camaghy Hill
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director159006020001
    MURTAGH, Gene
    Ballybarrack House
    Ardee Road
    IRISH Dundalk
    Co. Louth
    Ireland
    Administrateur
    Ballybarrack House
    Ardee Road
    IRISH Dundalk
    Co. Louth
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director66920570002
    DAWSON, Helen
    6 Welford Road
    Chapel Brampton
    NN6 8AF Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    6 Welford Road
    Chapel Brampton
    NN6 8AF Northampton
    Northamptonshire
    British86219590001
    EVANS, Martyn William
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    EnglishDirector78019510001
    ZANT BOER, Ian
    Grange Meadow
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Grange Meadow
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    British80009300001
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Secrétaire désigné
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004530001
    AUSTEN, Patrick George
    15 Lakeside Drive
    KT10 9EZ Esher
    Surrey
    Administrateur
    15 Lakeside Drive
    KT10 9EZ Esher
    Surrey
    United KingdomBritishDirector55015730002
    BARNES, Graham Leslie
    104 Tressillian Road
    Brockley
    SE4 1XX London
    Administrateur
    104 Tressillian Road
    Brockley
    SE4 1XX London
    UkBritishDirector14145910002
    EVANS, John Russell
    5 Wyndham Wood Close
    Fradley
    WS13 8UZ Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    5 Wyndham Wood Close
    Fradley
    WS13 8UZ Lichfield
    Staffordshire
    BritishEngineer46914950003
    EVANS, Jonathan Leslie, Dr
    Covert View Cross Hayes
    Maker Lane
    DE13 8QR Hoar Cross
    Staffordshire
    Administrateur
    Covert View Cross Hayes
    Maker Lane
    DE13 8QR Hoar Cross
    Staffordshire
    BritishEngineer42254810004
    EVANS, Martyn William
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    EnglandEnglishDirector78019510001
    FELL, Nigel Anthony Russell
    Low Hall Pavilion
    Hackness Road Scalby
    YO13 0QY Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Low Hall Pavilion
    Hackness Road Scalby
    YO13 0QY Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector73837700002
    MCCARTHY, Gilbert
    Forrest Haven
    Cabra, Kingscourt
    Co. Cavan
    Forrest Haven
    Ireland
    Administrateur
    Forrest Haven
    Cabra, Kingscourt
    Co. Cavan
    Forrest Haven
    Ireland
    IrelandIrishDirector155528060001
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Administrateur
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director145024250001
    MURTAGH, Brendan
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    Administrateur
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    IrishDirector30924190002
    O'SULLIVAN, Patrick
    Carragoona,
    IRISH Bray Road
    Co. Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Carragoona,
    IRISH Bray Road
    Co. Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director116309670001
    RIDGEWELL, Brian John, Dr
    Lower Barn Fields Road
    Chedworth
    GL54 4NJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Lower Barn Fields Road
    Chedworth
    GL54 4NJ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishBritishManagement Consultant52685140001
    SKIVINGTON, John
    25 Sandfield Terrace
    GU1 4LN Guildford
    Surrey
    Administrateur
    25 Sandfield Terrace
    GU1 4LN Guildford
    Surrey
    BritishMarketing/Sales Director66957410001
    TIPPETT, Richard William
    11 Cranleigh Gardens
    BS9 1HD Stoke Bishop
    Bristol
    Administrateur
    11 Cranleigh Gardens
    BS9 1HD Stoke Bishop
    Bristol
    British AustralianDirector97578070001
    TREANOR, John Francis
    Orchard Cottage
    Whyle Lane, Brockmanton
    HR6 0RQ Leominster
    Orchard Cottage
    England
    Administrateur
    Orchard Cottage
    Whyle Lane, Brockmanton
    HR6 0RQ Leominster
    Orchard Cottage
    England
    EnglandBritishAccountant71980650001
    WILSON, Peter Charles
    Southbank Close
    22 Southbank Close
    HR1 2TQ Hereford
    22
    Herefordshire
    England
    Administrateur
    Southbank Close
    22 Southbank Close
    HR1 2TQ Hereford
    22
    Herefordshire
    England
    EnglandIrishCompany Director20983740023
    WOODLOCK, Henry
    14 Selborne Road
    Handsworth
    B20 2DW Birmingham
    Administrateur
    14 Selborne Road
    Handsworth
    B20 2DW Birmingham
    United KingdomBritishStructural Engineer95966360002
    WRIGHT, David
    49 Avenue Road
    LE65 2FA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Administrateur
    49 Avenue Road
    LE65 2FA Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    BritishDirector107062350001
    ZANT BOER, Ian
    Grange Meadow
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    Grange Meadow
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    BritishSolicitor80009300001
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900004520001

    KINGSPAN PROPERTY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 11 mars 2003
    Livré le 18 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings and the junction of bridgeman street and pleck road walsall west midlands title number WM236754.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 28 janv. 2003
    Livré le 29 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 29 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 août 2000
    Livré le 02 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a manor works pleck road walsall west midlands. T/no. SF108556 & WM236754. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 29 août 2000
    Livré le 01 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0