IGROUP BDA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIGROUP BDA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03675910
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IGROUP BDA LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe IGROUP BDA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IGROUP BDA LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OCWEN BDA LIMITED24 nov. 199824 nov. 1998

    Quels sont les derniers comptes de IGROUP BDA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour IGROUP BDA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pagesLIQ13

    Cessation de la nomination de Kalpna Shah en tant que secrétaire le 28 févr. 2018

    2 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY United Kingdom à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 07 mars 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 févr. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Déclaration de confirmation établie le 24 nov. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Richard William Bird en tant que directeur le 29 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente prolongée du 30 nov. 2016 au 31 mai 2017

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Laurence Anne Renee Perrin en tant que directeur le 30 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 24 nov. 2016 avec mises à jour

    10 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 16 nov. 2016

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Miss Samantha Jones en tant qu'administrateur le 10 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bernardus Petrus Maria Van Bunnik en tant que directeur le 01 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Building 4 Hatters Lane Croxley Green Business Park Watford Hertfordshire WD18 8YF à PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY le 23 août 2016

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2015

    23 pagesAA

    Cessation de la nomination de Manuel Uria-Fernandez en tant que directeur le 14 juin 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard William Bird en tant qu'administrateur le 14 juin 2016

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Manuel Uria-Fernandez le 17 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 nov. 2015

    État du capital au 27 nov. 2015

    • Capital: GBP 10,000,001
    SH01

    État du capital après une attribution d'actions au 15 sept. 2015

    • Capital: GBP 10,000,001
    3 pagesSH01

    Qui sont les dirigeants de IGROUP BDA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Samantha
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    United KingdomBritish216074420001
    SHAH, Kalpna
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Secrétaire
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    199403700001
    SHAH, Kalpna
    18 Vicarage Road
    WD18 0EH Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    18 Vicarage Road
    WD18 0EH Watford
    Hertfordshire
    British80753870001
    FN SECRETARY LIMITED
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    88740300002
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Secrétaire désigné
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    AINSWORTH, Keith
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    Administrateur
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    EnglandBritish46161840001
    BELLORA, Michael Richard
    Russet House
    1a Latchmoor Avenue
    SL9 8LL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Russet House
    1a Latchmoor Avenue
    SL9 8LL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    American98453650001
    BERRY, Duncan Gee
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    EnglandBritish107695600022
    BIRD, Richard William
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Administrateur
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    United KingdomBritish209298590001
    BOAKES, Jeremy Edward
    41 Sherrards Park Road
    AL8 7LD Welwyn Garden City
    Herts
    Administrateur
    41 Sherrards Park Road
    AL8 7LD Welwyn Garden City
    Herts
    British106122240001
    BRENNAN, Peter
    10 Ardross Avenue
    HA6 3DS Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    10 Ardross Avenue
    HA6 3DS Northwood
    Middlesex
    British84912240001
    CAMERON, Ewan Douglas
    13 Heathfield Gardens
    W4 4JU London
    Administrateur
    13 Heathfield Gardens
    W4 4JU London
    British122900270001
    CARSON, David Richard
    26 Loynells Road
    Rednal
    B45 9NP Birmingham
    Administrateur
    26 Loynells Road
    Rednal
    B45 9NP Birmingham
    British73271960002
    CRICHTON, Susan Elizabeth
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69358970001
    DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131081660001
    DEANE JOHNS, Simon Joshua
    61 Stanlake Road
    W12 7HG London
    Administrateur
    61 Stanlake Road
    W12 7HG London
    Australian80748330001
    DLUTOWSKI, Joseph Arthur
    13127 Silver Fox Lane
    Palm Beach Gardens
    Palm Beach County 33418
    United States Of America
    Administrateur
    13127 Silver Fox Lane
    Palm Beach Gardens
    Palm Beach County 33418
    United States Of America
    American66506120001
    ERBEY, William Charles
    110 Sunset Avenue Apartment 2b
    3947 Palm Beach
    Florida 33480-3947
    United Statesof America
    Administrateur
    110 Sunset Avenue Apartment 2b
    3947 Palm Beach
    Florida 33480-3947
    United Statesof America
    American58072470001
    EVANS, Kellie Victoria
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167417000001
    FERGUSON, Ian George
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish133318850001
    FLYNN, William John
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British99330320002
    GARDEN, Robert James
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152764360001
    GUNNIGLE, Clodagh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish138244630002
    HARRIS, Jeffrey
    9 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Northaw
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Northaw
    Hertfordshire
    American98233530002
    HARVEY, David
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish97086950001
    HARVEY, Richard John
    6 Heronsford
    West Hunsbury
    NN4 9XG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    6 Heronsford
    West Hunsbury
    NN4 9XG Northampton
    Northamptonshire
    British122892160001
    HUNKIN, Ricky David
    2 Hockeridge View
    Oakwood
    HP4 3NB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Hockeridge View
    Oakwood
    HP4 3NB Berkhamsted
    Hertfordshire
    British115390900001
    JOHAR, Mandeep Singh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIndian127046380002
    JOHNSON, Alec David
    12 The Witherings, Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    Administrateur
    12 The Witherings, Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    United KingdomBritish103446140001
    KAGAN, Jeffrey Allan
    14 Norrice Lea
    N2 0RE London
    Administrateur
    14 Norrice Lea
    N2 0RE London
    Australian78535300001
    MILLWARD, Keith Roger
    Le Marque Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Le Marque Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80388420001
    PERRIN, Laurence Anne Renee
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Administrateur
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    United KingdomFrench183220720001
    PICKERING, Steven Mark
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Administrateur
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United KingdomBritish164833430002
    PUNCH, Andrew Robert
    Pepys Way
    6 Ford Road
    GU24 9EJ Bisley
    Surrey
    Administrateur
    Pepys Way
    6 Ford Road
    GU24 9EJ Bisley
    Surrey
    United KingdomBritish147703850001
    SANDERS, Colin George
    Burleigh Grange
    Nightingales Lane
    HP8 4SR Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Burleigh Grange
    Nightingales Lane
    HP8 4SR Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British81421480002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IGROUP BDA LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    08 sept. 2016
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5128935
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Hatters Lane
    2497
    WD18 1YY Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Hatters Lane
    2497
    WD18 1YY Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueUnlimited With Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06440028
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    IGROUP BDA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge
    Créé le 06 avr. 2001
    Livré le 20 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations (whether actual or contingent, present and future) of the company owing or owed to the chargee under the terms loan facility dated 1ST october 1999, the coupon facility dated 12TH january 2000, the coupon facility dated 26TH april 2000, the coupon facility dated 15TH august 2000, the coupon facility dated 20TH november 2000 and the finance documents
    Brèves mentions
    By way of first fixed security all of the borrower's rights and benefits under the custody agreement; all of the borrower's rights title and interest in and to the coupon securities and all sums payable or which become payable in respect of the coupon securities;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 06 avr. 2001
    Livré le 20 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations (whether actual or contingent, present and future) of the company owing or owed to the chargee under the terms loan facility dated 1ST october 1999, the coupon facility dated 12TH january 2000, the coupon facility dated 26TH april 2000, the coupon facility dated 15TH august 2000, the coupon facility dated 20TH november 2000 and the finance documents
    Brèves mentions
    The coupon securities and any cash balances standing from time to time to the credit of the collateral account (as more particularly defined in the pledge).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 20 nov. 2000
    Livré le 30 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1ST october 1999 and a deed of charge dated 1ST october 1999 and/or the coupon facility dated 12TH january 2000 and a deed of charge dated 12TH january 2000 and/or the coupon facility dated 26TH april 2000 and the deed of charge dated 26TH april 2000 and/or the coupon facility dated 15TH august 2000 and the deed of charge dated 15TH august 2000 and/or the finance documents (as defined) as such documents may be amended from time to time
    Brèves mentions
    All of the borrower's rights and benefits under the custody agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 20 nov. 2000
    Livré le 30 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1 october 1999 and a deed of charge of the same date and/or the coupon facility dated 12 january 2000 and a deed of charge of the same date and/or the coupon facility dated 26 april 2000 and a deed of charge of the same date and/or the coupon facility dated 15 august 2000 and a deed of charge of the same date and/or the finance documents (all as defined therein)
    Brèves mentions
    The pledgor pledged the charged assets (as defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 06 sept. 2000
    Livré le 16 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1 october 1999 and deed of charge dated 1 october 1999 and/or the coupon facility dated 12 january 2000 and a deed of charge dated 12 january 2000 and/or the finance documents
    Brèves mentions
    By way of first fixed security all rights and benefits under the custody agreement and to the coupon securities and all sums payable in respect of the coupon securities and all rights title and interest in and to the coupon account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 06 sept. 2000
    Livré le 16 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 1 october 1999 and deed of charge dated 1 october 1999 and/or the coupon facility dated 12 january 2000 and deed of charge dated 12 january 2000 and/or the finance documents
    Brèves mentions
    The charged assets meaning the coupon securities and any cash balances standing from time to time to the credit of the collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 15 août 2000
    Livré le 24 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under (a) the term loan facility dated 1 october 1999 and a deed of charge dated 1 october 1999,(b) the coupon facility dated 12 january 2000 and a deed of charge dated 12 january 2000 and/or (c) the coupon facility dated 26 april 2000 and the deed of charge dated 26 april 2000 and/or (d) the finance documents (all terms as defined)
    Brèves mentions
    The charged assets,as defined, and any cash balances from time to time standing to the credit of the collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 15 août 2000
    Livré le 24 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility dated 01/10/99, the coupon facility dated 12/01/00 and 26/04/00 and the finance documents
    Brèves mentions
    All of the borrowers rights and benefits under the custody agreement and other agreements and accounts the details of which are listed on the form 395.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 12 janv. 2000
    Livré le 20 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a term loan facility dated 1 october 1999
    Brèves mentions
    The pledgor pledged the charged assets to the pledgee as security for the due perfrmance of the secured liabilities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 12 janv. 2000
    Livré le 20 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a term loan facility dated 1 october 1999
    Brèves mentions
    The borrower with full title guarantee and as continuing security for the secured liabilities by way of first fixed security all the rights and benefits under the custody agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 01 oct. 1999
    Livré le 12 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the term loan facility the guarantee the pledge agreement an any other document pursuant to which the company owes any obligation to the chargee from time to time
    Brèves mentions
    All the company's rights and benefits under the custody agreement, all right title and interest in and to the charged securities and all monies derived therefrom and all of the company's right title benefit and interest in and to the ocwen bda limited account together with floating charge all present and future undertakings assets and rights not charged by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 01 oct. 1999
    Livré le 12 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and obligations (whether actual or contingent, present or future) of the company to the chargee under the term loan facility, the guarantee and the deed of charge.
    Brèves mentions
    The pledgor pledged the charged securities and any cash balances standing from time to time to the credit of the collateral account.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 11 juin 1999
    Livré le 25 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations of the company to the chargee under the secured term loan facility dated 4TH december 1998 and the finance documents
    Brèves mentions
    All the borrowers rights and benefits under the custody agreement, the coupon securities and all sums payable in respect of the coupon securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Pledge agreement
    Créé le 11 juin 1999
    Livré le 25 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations (whether actual or contingent, present or future) of the company to the chargee under (a) a secured term loan facility dated 4TH december 1998 and a deed of charge dated 4TH december 1998; and (b) the finance documents
    Brèves mentions
    The pldgor pledged the charged assets to the pledgee,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 04 déc. 1998
    Livré le 18 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations of the company to the chargee under the secured term loan facility dated 4TH december 1998
    Brèves mentions
    All the borrowers rights and benefits under the custody agreement, the charged securities and all sums payable in respect of the charged securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    IGROUP BDA LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 févr. 2018Commencement of winding up
    23 nov. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0