WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED

WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03754359
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED ?

    • Production d'électricité (35110) / Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

    Où se situe WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6th Floor 33 Holborn
    EC1N 2HT London
    England
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 29 nov. 2019

    • Capital: GBP 0.01
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    The issued shares capital of the company redeuced from £37,485.59 to £0.01 by cancelling and extinguishing 3,748,558 ordinary shares of £0.01 each in the capital of the company 13/11/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 25 avr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Octopus Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 15 nov. 2018

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Sharna Ludlow en tant que secrétaire le 15 nov. 2018

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Stephen Latham le 07 sept. 2018

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Company Secretary Sharna Ludlow le 25 avr. 2018

    1 pagesCH03

    Déclaration de confirmation établie le 25 avr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Company Secretary Sharna Ludlow le 16 mars 2018

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Kamalika Ria Banerjee en tant que secrétaire le 19 févr. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Kamalika Ria Banerjee en tant que secrétaire le 30 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Paul Stephen Latham en tant qu'administrateur le 15 août 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 27 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew George Setchell le 20 févr. 2017

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Tim James Senior en tant que directeur le 06 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Matthew George Setchell en tant qu'administrateur le 06 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT

    2 pagesAD04

    Qui sont les dirigeants de WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OCTOPUS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    Secrétaire
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement11677818
    253893850001
    LATHAM, Paul Stephen
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Administrateur
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    United KingdomBritish146527710002
    SETCHELL, Matthew George
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Administrateur
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    EnglandBritish157021230004
    WILKINSON, Edwin John
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish86926370001
    BANERJEE, Kamalika Ria
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Secrétaire
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    239579570001
    FITZHERBERT, David Henry
    12 Gordon Place
    W8 4JD London
    Secrétaire
    12 Gordon Place
    W8 4JD London
    Irish74254060001
    GOOLD, James Edward Ian
    37 Lavender Sweep
    SW11 1DY London
    Secrétaire
    37 Lavender Sweep
    SW11 1DY London
    British63011810002
    LUDLOW, Sharna, Company Secretary
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    Secrétaire
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    208745520001
    PENTECOST, Alexandra Helen
    2 Stratton Villas
    Milbourne
    SN16 9JB Malmesbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    2 Stratton Villas
    Milbourne
    SN16 9JB Malmesbury
    Wiltshire
    British70254590001
    WARD, Karen
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Secrétaire
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    204136920001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    FITZHERBERT, David Henry
    12 Gordon Place
    W8 4JD London
    Administrateur
    12 Gordon Place
    W8 4JD London
    United KingdomIrish74254060001
    GOOLD, James Edward Ian
    37 Lavender Sweep
    SW11 1DY London
    Administrateur
    37 Lavender Sweep
    SW11 1DY London
    British63011810002
    HOLMES, Randall Duane
    36 Neustadt Lane
    10514 Chappaqua
    New York Ny 10514
    Usa
    Administrateur
    36 Neustadt Lane
    10514 Chappaqua
    New York Ny 10514
    Usa
    American64549270001
    PATON, John Derek
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish76165310001
    SENIOR, Timothy James, Dr
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Administrateur
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    EnglandBritish244462470001
    SWANSON, Robert Ernest
    119 Turtle Point Road
    Tuxedo Park
    New York 10987
    Usa
    Administrateur
    119 Turtle Point Road
    Tuxedo Park
    New York 10987
    Usa
    American95188450001
    THORNEYCROFT, Maxwell Bennett
    80 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    Administrateur
    80 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    United KingdomBritish3367180002
    TILSTONE, David Paul
    12 Manor Road
    TN4 8UE Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    12 Manor Road
    TN4 8UE Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish117871440001
    WEST, Andrew Thomas
    4 Filkins Hall
    Filkins
    GL7 3JJ Lechdale
    Gloucestershire
    Administrateur
    4 Filkins Hall
    Filkins
    GL7 3JJ Lechdale
    Gloucestershire
    United KingdomBritish79568920001
    WILSON, Douglas Ralph
    312 Highland Avenue
    07450 Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    Administrateur
    312 Highland Avenue
    07450 Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    American91734800002
    WYNDHAM, Harry Hugh Patrick
    56 Stockwell Park Crescent
    SW9 0DG London
    Administrateur
    56 Stockwell Park Crescent
    SW9 0DG London
    EnglandBritish37118660001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    06 avr. 2016
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03966429
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 21 janv. 2010
    Livré le 22 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank, UK Branch
    Transactions
    • 22 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 22 févr. 2007
    Livré le 09 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All land equipment insurances debts goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V. on Behalf of Itself and the Finance Parties
    Transactions
    • 09 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 04 mai 2006
    Livré le 17 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company,by each borrower and each other project company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its interest in the property,together with all buildings and fixtures thereon,the proceeds of sale of all or any part thereof and the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession
    Créé le 16 oct. 2001
    Livré le 30 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and all obligations and liabilities due or to become due by the chargor to the chargee (the bank) under or pursuant to the composite guarantee and debenture dated 30TH june 2000 and the deed of accession and all moneys and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the bank (including without limitation all moneys and liabilities due owing or incurred under or pursuant to the facility agreement) by each other company on any account whatsoever (all terms as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 03 juil. 2000
    Livré le 21 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0