SANITEC UK LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SANITEC UK LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 04066175 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SANITEC UK LIMITED ?
Adresse du siège social | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent Staffordshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SANITEC UK LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour SANITEC UK LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2015 au 31 mars 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Nomination de Mrs Christine Chitty en tant que secrétaire le 14 déc. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bbm Secretaries Limited en tant que secrétaire le 14 déc. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Karl Spachmann en tant qu'administrateur le 16 oct. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Roland Iff en tant qu'administrateur le 16 oct. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephanie Kenway en tant que directeur le 16 oct. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Juuso Sillanpaa en tant que directeur le 16 oct. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gun Nilsson en tant que directeur le 18 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 16 pages | AA | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 17 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 27 sept. 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mrs Stephanie Kenway en tant qu'administrateur le 02 juil. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Kenneth Blackburn en tant que directeur le 02 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 040661750004 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 12 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SANITEC UK LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHITTY, Christine | Secrétaire | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent Staffordshire | 204100450001 | |||||||||||
IFF, Roland | Administrateur | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent Staffordshire | Switzerland | Switzerland | Chief Financial Officer | 201914470001 | ||||||||
SPACHMANN, Karl | Administrateur | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent Staffordshire | Switzerland | German | Head Of European Divisional Sales | 201918430001 | ||||||||
LEHTO, Timo | Secrétaire | Kapylantie 46 FOREIGN Helsinki 00600 Finland | Finnish | Company Director | 74036010001 | |||||||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Secrétaire désigné | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||||||
BBM SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Lakeside, Festival Way ST1 5RY Stoke-On-Trent Sigma House Staffordshire Great Britain |
| 124385980001 | ||||||||||
EVERSECRETARY LIMITED | Secrétaire | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||||||
BLACKBURN, John Kenneth | Administrateur | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke-On-Trent Staffordshire United Kingdom | England | British | None | 113390120001 | ||||||||
BROWN, Alan Derek | Administrateur | 2 Hassam Parade Wolstanton ST5 9DS Newcastle Staffordshire | England | British | Finance Director | 74066170001 | ||||||||
BRUNOW, Berndt | Administrateur | Itainen Puistotie 5a FOREIGN Helsinki 00140 Finland | Finnish | Comapny Director | 74035820002 | |||||||||
CONLON, Michael Gerard | Administrateur | 78 Demontfort Way ST14 8XY Uttoxeter Staffordshire | United Kingdom | Irish | Director | 96832770001 | ||||||||
KENWAY, Stephanie | Administrateur | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent Staffordshire | England | British | Head Of Finance And Hr | 189382080001 | ||||||||
LEHTO, Timo | Administrateur | Kapylantie 46 FOREIGN Helsinki 00600 Finland | Finnish | Company Secretary | 74036010001 | |||||||||
MAHER, Diana | Administrateur | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent Staffordshire | Finland | Finnish | Director | 148987110001 | ||||||||
NILSSON, Gun | Administrateur | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke-On-Trent Staffordshire | Sweden | Swedish | Director | 158150790001 | ||||||||
NUPPONEN, Pertti | Administrateur | Vainamoisenkatu 29 A 10 FOREIGN Helsinki 00100 Finland | Finnish | Company Director | 74035980001 | |||||||||
PICKERING, Mark Ian | Administrateur | 54 Broadway Road WR11 1BQ Evesham Worcestershire | England | British | Company Director | 107375670001 | ||||||||
SILLANPAA, Juuso | Administrateur | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent Staffordshire | Finland | Finnish | Lawyer | 177405760001 | ||||||||
STRAND-KURKI-SUONIO, Laura | Administrateur | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke-On-Trent Staffordshire United Kingdom | Finland | Finnish | None | 159391470002 | ||||||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Administrateur désigné | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED | Administrateur désigné | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002910001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SANITEC UK LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
---|---|---|---|
Mr Roland Iff | 30 juin 2016 | Lawton Road Alsager ST7 2DF Stoke On Trent Staffordshire | Non |
Nationalité: Swiss Pays de résidence: Switzerland | |||
Nature du contrôle
|
SANITEC UK LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 10 mai 2013 Livré le 13 mai 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description N/A. notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A composite debenture | Créé le 08 juil. 2009 Livré le 16 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 mai 2005 Livré le 01 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 31 janv. 2002 Livré le 13 févr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0