SANITEC UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSANITEC UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04066175
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SANITEC UK LIMITED ?

    • Commerce de gros en bois, matériaux de construction et équipements sanitaires (46730) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe SANITEC UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SANITEC UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALNERY NO. 2094 LIMITED06 sept. 200006 sept. 2000

    Quels sont les derniers comptes de SANITEC UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour SANITEC UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2015 au 31 mars 2016

    1 pagesAA01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Nomination de Mrs Christine Chitty en tant que secrétaire le 14 déc. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Bbm Secretaries Limited en tant que secrétaire le 14 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Karl Spachmann en tant qu'administrateur le 16 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Roland Iff en tant qu'administrateur le 16 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephanie Kenway en tant que directeur le 16 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Juuso Sillanpaa en tant que directeur le 16 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gun Nilsson en tant que directeur le 18 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 sept. 2015

    État du capital au 11 sept. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    17 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 27 sept. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 sept. 2014

    État du capital au 08 sept. 2014

    • Capital: GBP 86,087,108
    SH01

    Nomination de Mrs Stephanie Kenway en tant qu'administrateur le 02 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Kenneth Blackburn en tant que directeur le 02 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 040661750004 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SANITEC UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHITTY, Christine
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    204100450001
    IFF, Roland
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    SwitzerlandSwitzerlandChief Financial Officer201914470001
    SPACHMANN, Karl
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    SwitzerlandGermanHead Of European Divisional Sales201918430001
    LEHTO, Timo
    Kapylantie 46
    FOREIGN Helsinki
    00600
    Finland
    Secrétaire
    Kapylantie 46
    FOREIGN Helsinki
    00600
    Finland
    FinnishCompany Director74036010001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secrétaire désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BBM SECRETARIES LIMITED
    Lakeside, Festival Way
    ST1 5RY Stoke-On-Trent
    Sigma House
    Staffordshire
    Great Britain
    Secrétaire
    Lakeside, Festival Way
    ST1 5RY Stoke-On-Trent
    Sigma House
    Staffordshire
    Great Britain
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04653323
    124385980001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    BLACKBURN, John Kenneth
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishNone113390120001
    BROWN, Alan Derek
    2 Hassam Parade
    Wolstanton
    ST5 9DS Newcastle
    Staffordshire
    Administrateur
    2 Hassam Parade
    Wolstanton
    ST5 9DS Newcastle
    Staffordshire
    EnglandBritishFinance Director74066170001
    BRUNOW, Berndt
    Itainen Puistotie 5a
    FOREIGN Helsinki
    00140
    Finland
    Administrateur
    Itainen Puistotie 5a
    FOREIGN Helsinki
    00140
    Finland
    FinnishComapny Director74035820002
    CONLON, Michael Gerard
    78 Demontfort Way
    ST14 8XY Uttoxeter
    Staffordshire
    Administrateur
    78 Demontfort Way
    ST14 8XY Uttoxeter
    Staffordshire
    United KingdomIrishDirector96832770001
    KENWAY, Stephanie
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishHead Of Finance And Hr189382080001
    LEHTO, Timo
    Kapylantie 46
    FOREIGN Helsinki
    00600
    Finland
    Administrateur
    Kapylantie 46
    FOREIGN Helsinki
    00600
    Finland
    FinnishCompany Secretary74036010001
    MAHER, Diana
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    FinlandFinnishDirector148987110001
    NILSSON, Gun
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    SwedenSwedishDirector158150790001
    NUPPONEN, Pertti
    Vainamoisenkatu 29 A 10
    FOREIGN Helsinki
    00100
    Finland
    Administrateur
    Vainamoisenkatu 29 A 10
    FOREIGN Helsinki
    00100
    Finland
    FinnishCompany Director74035980001
    PICKERING, Mark Ian
    54 Broadway Road
    WR11 1BQ Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    54 Broadway Road
    WR11 1BQ Evesham
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director107375670001
    SILLANPAA, Juuso
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    FinlandFinnishLawyer177405760001
    STRAND-KURKI-SUONIO, Laura
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    United Kingdom
    FinlandFinnishNone159391470002
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Administrateur désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Administrateur désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SANITEC UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Roland Iff
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    30 juin 2016
    Lawton Road
    Alsager
    ST7 2DF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Non
    Nationalité: Swiss
    Pays de résidence: Switzerland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    SANITEC UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 mai 2013
    Livré le 13 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wilmington Trust (London) Limited
    Transactions
    • 13 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A composite debenture
    Créé le 08 juil. 2009
    Livré le 16 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, Frankfurt Branch (The Security Trustee)
    Transactions
    • 16 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 mai 2005
    Livré le 01 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 janv. 2002
    Livré le 13 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag ("the Security Agent")
    Transactions
    • 13 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0