CAV AEROSPACE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAV AEROSPACE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04069894
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAV AEROSPACE LIMITED ?

    • fabrication d'aéronefs et de vaisseaux spatiaux et de machines connexes (30300) / Industries manufacturières

    Où se situe CAV AEROSPACE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAV AEROSPACE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AEROSPACE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES 2000 LIMITED01 juin 200101 juin 2001
    CELTIC AEROSPACE VENTURES LIMITED07 nov. 200007 nov. 2000
    FILBUK 632 LIMITED12 sept. 200012 sept. 2000

    Quels sont les derniers comptes de CAV AEROSPACE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CAV AEROSPACE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    19 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    17 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    17 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    17 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B/2.15B

    10 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    50 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    47 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Number 1 Industrial Estate Consett County Durham DH8 6SR à 4 Brindley Place Birmingham B1 2HZ le 30 nov. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Déclaration de confirmation établie le 12 sept. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Michael John Eggleston en tant que directeur le 03 juin 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2015

    30 pagesAA

    Inscription de la charge 040698940025, créée le 22 mars 2016

    9 pagesMR01

    Inscription de la charge 040698940026, créée le 22 mars 2016

    9 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 040698940018 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 040698940019 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 040698940017 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 040698940020 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 040698940022 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de CAV AEROSPACE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    Secrétaire
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    196460680001
    ASPLIN, Robert Alexander
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    Administrateur
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritish149870270004
    MILNER, Andrew Rex
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    Administrateur
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritish200109020001
    CASSIDY, Peter Antony
    6 Chester Close
    Darras Hall
    NE20 9AG Ponteland
    Newcastle On Tyne
    Secrétaire
    6 Chester Close
    Darras Hall
    NE20 9AG Ponteland
    Newcastle On Tyne
    British80630710001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Sun Alliance House 35 Mosley Street
    NE1 1XX Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire
    Sun Alliance House 35 Mosley Street
    NE1 1XX Newcastle Upon Tyne
    60471940003
    FILBUK (SECRETARIES) LIMITED
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire désigné
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    900004990001
    MUCKLE SECRETARY LIMITED
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Secrétaire
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5276019
    101749170003
    ALDRIDGE, Mark Nicholas Kennedy
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    Administrateur
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    United KingdomBritish196502740001
    CALLAGHAN, Anthony James
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Administrateur
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish109785120001
    CASSIDY, Peter Antony
    6 Chester Close
    Darras Hall
    NE20 9AG Ponteland
    Newcastle On Tyne
    Administrateur
    6 Chester Close
    Darras Hall
    NE20 9AG Ponteland
    Newcastle On Tyne
    United KingdomBritish80630710001
    EGGLESTON, Michael John
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    Administrateur
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    United KingdomBritish197706470001
    HUMPHREYS, Bryan Ernest
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Administrateur
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish7232710002
    JONES, Andrew David Willis
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Administrateur
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish80652540001
    KENNEDY, Harry
    21 Longbank Drive
    KA7 4SD Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    21 Longbank Drive
    KA7 4SD Ayr
    Ayrshire
    British70801300001
    LARGE, Leslie Arthur
    5 Wensley Drive
    Hazel Grove
    SK7 6EW Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    5 Wensley Drive
    Hazel Grove
    SK7 6EW Stockport
    Cheshire
    British80631410001
    LYLE, John Thomas
    115 Kenton Road
    NE3 4NN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    115 Kenton Road
    NE3 4NN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish66547550001
    MCFARLANE, Owen David
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Administrateur
    Time Central
    32 Gallowgate
    NE1 4BF Newcastle Upon Tyne
    C/O Muckle Llp
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish56110830005
    MCKINLAY, Robert Murray
    43 Glenavon Park
    BS9 1RW Bristol
    Administrateur
    43 Glenavon Park
    BS9 1RW Bristol
    British8393690001
    MOTTERSHEAD, Peter David Leigh
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    Administrateur
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    EnglandBritish102140470001
    MOULTON, Jonathan Paul
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    Administrateur
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number 1
    County Durham
    GuernseyBritish148687630003
    SCHUBERT, David Karl
    Baglan Villas
    Penybryn Pyle
    CF33 6RB Bridgend
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    Baglan Villas
    Penybryn Pyle
    CF33 6RB Bridgend
    Mid Glamorgan
    WalesBritish4611080001
    SPENCER, Christopher Robin
    5 The Orchards
    NG31 9GW Grantham
    Lincolnshire
    Administrateur
    5 The Orchards
    NG31 9GW Grantham
    Lincolnshire
    British100793720001
    FILBUK NOMINEES LIMITED
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    Administrateur désigné
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    900004980001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAV AEROSPACE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number One
    County Durham
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Industrial Estate
    DH8 6SR Consett
    Number One
    County Durham
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act, 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement09464809
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    CAV AEROSPACE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 mars 2016
    Livré le 26 mars 2016
    En cours
    Brève description
    Unit 24 number one industrial estate consett t/no DU180793.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • BECAP12 Cav Aerospace Limited
    Transactions
    • 26 mars 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 mars 2016
    Livré le 26 mars 2016
    En cours
    Brève description
    Unit 24 number one industrial estate consett t/no DU180793.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • BECAP12 Cav Aerospace Limited
    Transactions
    • 26 mars 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 janv. 2016
    Livré le 28 janv. 2016
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • BECAP12 Cav Aerospace Limited
    Transactions
    • 28 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 janv. 2016
    Livré le 28 janv. 2016
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • BECAP12 Cav Aerospace Limited
    Transactions
    • 28 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 19 mars 2015
    Livré le 24 mars 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Unit 11 ashville way whetstone t/no LT331487 and BT101/24 number one industrial estate medomsley road consett t/no DU180793 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (as Security Trustee)
    Transactions
    • 24 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 19 mars 2015
    Livré le 26 mars 2015
    En cours
    Brève description
    1) unit 11, ashville way, whetstone, LE8 6NU. Title number: LT331487. 2) BT101/24 number one industrial estate, medomsley road, consett. Title number: DU180793.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • BECAP12 Spv 18 Limited
    Transactions
    • 26 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 17 mars 2015
    Livré le 19 mars 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (as Security Trustee)
    Transactions
    • 19 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 mars 2015
    Livré le 19 mars 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited (as Security Trustee)
    Transactions
    • 19 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 25 févr. 2014
    Livré le 15 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 15 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 25 févr. 2014
    Livré le 15 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 15 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 oct. 2013
    Livré le 08 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Leasing Limited
    Transactions
    • 08 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 03 août 2012
    Livré le 08 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form MG01 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Barclays bank PLC re cav aerospace limited. Business premium account. Account number 43048632.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of debenture
    Créé le 20 oct. 2010
    Livré le 27 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 27 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2009
    Livré le 30 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transactions
    • 30 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 02 déc. 2005
    Livré le 10 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 1 no 1 industrial estate consett. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All assets debenture
    Créé le 27 sept. 2005
    Livré le 29 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge on all f/h and l/h property,all fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings and fixed plant and machinery,all spare parts,replacements,modifications and additions,all goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • London Bridge Finance Limited
    Transactions
    • 29 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 août 2005
    Livré le 03 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 31 août 2005
    Livré le 03 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 11 ashville way, whetstone, leicester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 31 août 2005
    Livré le 03 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a number one industrial estate, medomsley road, consett, county durham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattel mortgage
    Créé le 02 oct. 2003
    Livré le 15 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The hydroflow central coolant, swarf filtration system and boric acid anodising tank together with all additions alterations accessories replacements, substitutions and renewals (the mortgaged chattels) with the full benefit of any guarantee warranty or other obligation, agreements copyrights and insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 21 mars 2002
    Livré le 10 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    BT101/24, number one ind. Estate, medomsley road, consett, t/no DU180793. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 21 mars 2002
    Livré le 10 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The plant machinery chattels or other equipment, the benefit of any guarantee, agreements, copyrights, patents, trademarks etc, the benefit of all insurances.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2002
    Livré le 05 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 19 déc. 2001
    Livré le 05 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn therefrom, deposit account means: a separate interest earning deposit account(s) maintained by the mortgagee into which the initial deposit of £13,218.75 shall be paid.
    Personnes ayant droit
    • Norscot Investments Limited
    Transactions
    • 05 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 janv. 2001
    Livré le 15 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CAV AEROSPACE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 nov. 2016Administration started
    07 sept. 2019Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Robert James Harding
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0