PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED

PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04132575
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED ?

    • Autre vente au détail non en magasin, sur les stands ou marchés (47990) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles
    • Location et location d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77390) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LAW 2251 LIMITED29 déc. 200029 déc. 2000

    Quels sont les derniers comptes de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Mark Peter Evans en tant que secrétaire le 24 mai 2018

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Mark Peter Evans en tant que directeur le 24 mai 2018

    1 pagesTM01

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    22 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    28 pagesAM10

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    40 pagesAM03

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    19 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de Unit 4 Boundary Court Willow Farm Business Park Castle Donington Derbyshire DE74 2UD à Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 30 mars 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 févr. 2016

    État du capital au 03 févr. 2016

    • Capital: GBP 126,250
    SH01

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 mars 2015

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 janv. 2015

    État du capital au 12 janv. 2015

    • Capital: GBP 126,250
    SH01

    Cessation de la nomination de John Pinkney en tant que directeur le 25 mars 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Wayne Homes en tant que directeur le 25 mars 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen Vernon Bradley en tant que directeur le 25 mars 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 mars 2014

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 janv. 2014

    État du capital au 15 janv. 2014

    • Capital: GBP 126,250
    SH01

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 mars 2013

    17 pagesAA

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 31 mars 2012

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    6 pagesMG01

    Qui sont les dirigeants de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ECCLESHALL, Christopher James
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    Administrateur
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    EnglandBritish100000660001
    EVANS, Mark Peter
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    British78582200002
    FREARSON, Richard
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    British50961700001
    EVERSECRETARY LIMITED
    1 Royal Standard Place
    NG1 6FZ Nottingham
    Secrétaire
    1 Royal Standard Place
    NG1 6FZ Nottingham
    60471940015
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secrétaire
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    61729550001
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secrétaire désigné
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900018860001
    BRADLEY, Stephen Vernon
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish38805680002
    BRAMHALL, Darren
    Unit 9b
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UB Castle Donnington
    Derbyshire
    Administrateur
    Unit 9b
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UB Castle Donnington
    Derbyshire
    United KingdomBritish139463440001
    BRAMHILL, Darren
    119 Park Lane
    DE74 2JG Castle Donington
    Derbyshire
    Administrateur
    119 Park Lane
    DE74 2JG Castle Donington
    Derbyshire
    United KingdomBritish117298110001
    EVANS, Mark Peter
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    Administrateur
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    EnglandBritish78582200002
    FREARSON, Richard
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    British50961700001
    HOMES, David Wayne
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154849800001
    PINKNEY, John
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154856180001
    RATCLIFFE, Eric George
    16 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    16 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish32530880003
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Administrateur désigné
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008150001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Administrateur désigné
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    09 déc. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over sub-hire agreements
    Créé le 15 oct. 2012
    Livré le 23 oct. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The secured property, being- all right title interest and benefit in and to the sub-hire agreements see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 23 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 01 mai 2008
    Livré le 07 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Chattels mortgage
    Créé le 19 nov. 2004
    Livré le 20 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery. 32FT x 10FT special jack leg unit. Fleet no:ccns-102 s/no 105/3/D531. 32FT x 10FT special jack leg unit. Fleet no: ccns-103 s/no 105/3/D532.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment (UK) Limited
    Transactions
    • 20 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 févr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Chattels mortgage
    Créé le 19 févr. 2004
    Livré le 20 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Jack leg office/mess cabin units - s/nos 3/8062, 3/8063, s/8060, 3/8244, s/8692, 3/8957, 3/9056, 3/9070, 3/9101, 3/8982, N576, N594, N662, 3/8942. pallet racking s/no:B0051. Tiger hoist s/no's 777432-777437.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 20 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 18 déc. 2003
    Livré le 19 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule such as welding stands and frames with dustribution boards and accessories. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 08 oct. 2003
    Livré le 09 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    50 mastertig 350 mls welding machines,ser/nos 1108570,1108571,1108572 with all chattels plant machinery and things thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment (UK) Limited
    Transactions
    • 09 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 24 sept. 2003
    Livré le 25 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule being isuzu tf mega 2.5 tdi D. cab 4X4, chassis no. JAATFS54H27103683 pallet racking, s/no. D0336.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 25 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 18 juin 2003
    Livré le 20 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery 50 x mastertig 3500MLS welding machines serial numbers: 1096417, 1096418, 1097840 or any part thereof for further details of the property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 20 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 05 juin 2003
    Livré le 06 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things or any part thereof:- 53 mastertig 3500MLS welding machines s/nos, 1073780, 1079468, 992661, 1065190, 1065191, for further details of chattels charged with serial numbers please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 06 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 28 mai 2003
    Livré le 29 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 29 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 14 mars 2003
    Livré le 15 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto and the copy invoices attached hereto or any part thereof, schedule: vauxhall omega cdx V6, chassis no; WOLOVBM6911098696.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 15 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 11 févr. 2003
    Livré le 12 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    William hackett chains limited invoice numbers: op/0017699, OP0018057, OP0018460, OP0018520, OP0018020, hessle fork trucks limited invoice number 111756. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 12 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 05 févr. 2003
    Livré le 06 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the copy invoices attached to the form 395 or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 06 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 03 sept. 2002
    Livré le 03 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Vauxhall frontera 3.2I vg estate,reg/no NY02 uaw with all plant machinery and equipment thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 03 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 28 mars 2002
    Livré le 28 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2001 robin AR4001 digi multimeter - 5904. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 28 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge (all assets)
    Créé le 14 août 2001
    Livré le 16 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brèves mentions
    (I) all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts including associated rights relating thereto and (ii) all amounts of indebtedness due on any account whatsoever, all goodwill and uncalled capital, all patents and patent applications. The floating charge over the remainder of the underatking and all propery rights and assets whatsoever and wheresoever, both present and future including the company's stock in trade and its uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 16 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 juin 2001
    Livré le 12 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 12 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 mars 2017Administration started
    09 mars 2018Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0