G2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéG2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04390861
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de G2 LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe G2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Davidson House
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de G2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AIRTIME GROUP HOLDINGS LIMITED20 mars 200220 mars 2002
    DIGAME LIMITED08 mars 200208 mars 2002

    Quels sont les derniers comptes de G2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour G2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2010

    8 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 23/02/2011
    RES13

    État du capital au 14 mars 2011

    • Capital: GBP 1.00
    6 pagesSH19

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2009

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Smyth en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    13 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de G2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOGAN, Brenda Mary
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Secrétaire
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Other130814140001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    BritishFinance Director109659860001
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Administrateur
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrishDirector161364970001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglishChartered Accountant107835250001
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    BritishDirector42734310002
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Secrétaire
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    BritishCompany Director116252510001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Secrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    ABERNETHY, Kieron Quinn
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    Administrateur
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    United KingdomBritishDirector200594530001
    BEERLING, Kevin
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Administrateur
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    EnglandBritishDirector64677850002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglishChartered Accountant107835250001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector42734310002
    MCNAIR, John
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    Administrateur
    7 Westcombe Park Road
    SE3 7RE London
    BritishCompany Director61297520001
    MCNAMARA, Peter Denis
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector114555600001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Administrateur
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishDirector10402540005
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Administrateur
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    AmericanDirector130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Administrateur
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritishCompany Director116252510001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Administrateur
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    BritishDirector121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Administrateur
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    IrishDirector63863190002
    STANLEY, Paul Robert
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    BritishDirector58251370003
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Administrateur désigné
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Administrateur
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director92654710001

    G2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and
    Créé le 19 déc. 2005
    Livré le 06 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Syndicated debenture
    Créé le 19 déc. 2005
    Livré le 06 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 juil. 2005
    Livré le 15 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 15 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of deposit and charge
    Créé le 02 août 2002
    Livré le 21 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 02 août 2002
    Livré le 13 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or airtime interactive marketing LTD to the chargee on account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0