NNT LIFT COMPANY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | NNT LIFT COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04934392 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NNT LIFT COMPANY LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 Park Row LS1 5AB Leeds United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NNT LIFT COMPANY LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NNT LIFT COMPANY LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 25 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour NNT LIFT COMPANY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 mars 2025 | 19 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Sarah Louise Heslop en tant qu'administrateur le 01 sept. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Iain Michael Betham en tant que directeur le 31 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Mark Nicholson en tant qu'administrateur le 14 août 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Michelle Frances Percy en tant que directeur le 14 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Phillip Campbell Stewart en tant que directeur le 13 juin 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Kirstine Jane Hyde en tant qu'administrateur le 04 nov. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Adrian James Hill en tant que directeur le 30 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2024 | 19 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Jane Angela Coates le 23 sept. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Nomination de Mr Adrian James Hill en tant qu'administrateur le 29 mai 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Elliot Cardno Robertson en tant que directeur le 29 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de John Stephen Gordon en tant que directeur le 29 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Peter Kenneth Johnstone en tant qu'administrateur le 29 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Nafees Arif en tant que directeur le 17 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Dr Jane Angela Coates en tant qu'administrateur le 24 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Notification de Community Health Partnerships Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||
Nomination de Mr Paul Phillip Campbell Stewart en tant qu'administrateur le 20 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2023 | 19 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 25 oct. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Mark James Thurston en tant que directeur le 18 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Steven Mcghee en tant qu'administrateur le 30 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Peter Kenneth Johnstone en tant que directeur le 30 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de NNT LIFT COMPANY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLIS LIMITED | Secrétaire | 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh Exchange Tower, 11th Floor Scotland |
| 285489620001 | ||||||||||
| FITCH, Jane Angela, Dr | Administrateur | Manchester One 53 Portland Street M1 3LD Manchester, Greater Manchester Suite 12b England England | England | British | 316326610002 | |||||||||
| HESLOP, Sarah Louise | Administrateur | Cobalt Business Park NE27 0BY Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear The Quadrant, The Silverlink North England England | England | British | 339694980001 | |||||||||
| HOLT, Robert Duncan | Administrateur | Baltic Place South Shore Road NE8 3AE Gateshead Floor 6 United Kingdom | England | British | 279257690001 | |||||||||
| HYDE, Kirstine Jane | Administrateur | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House Scotland Scotland | Scotland | British | 328938770001 | |||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Administrateur | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Scotland | British | 53299620003 | |||||||||
| MCGHEE, Steven John | Administrateur | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Scotland | British | 308702460001 | |||||||||
| NICHOLSON, Mark | Administrateur | NE1 8QL Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear Newcastle City Council - Civic Centre England England | England | British | 339156840001 | |||||||||
| BAND, James | Secrétaire | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House Stirlingshire | 197466150001 | |||||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Secrétaire | Baltic Place South Shore Road NE8 3AE Gateshead 4th Floor West Tower England | British | 53299620002 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Secrétaire | 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd Floor United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| ARIF, Nafees | Administrateur | Manchester One 53 Portland Street M1 3LD Manchester Suite 12b United Kingdom | England | British | 205771390001 | |||||||||
| BETHAM, Iain Michael | Administrateur | Quadrant The Silverlink North Cobalt Business Park NE27 0BY North Tyneside North Tyneside Council United Kingdom | United Kingdom | British | 201490110001 | |||||||||
| BURGE, Richard William Francis | Administrateur | Melville Street EH3 7JF Edinburgh 35 United Kingdom | Scotland | British | 114479400001 | |||||||||
| BURGE, Richard William Francis | Administrateur | Melville Street EH3 7JF Edinburgh 35 United Kingdom | Scotland | British | 114479400001 | |||||||||
| CHRISTIE, Rory William | Administrateur | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 11 Midlothian United Kingdom | United Kingdom | British | 183191460001 | |||||||||
| CHRISTIE, Rory William | Administrateur | Melville Street EH3 7JF Edinburgh 35 United Kingdom | United Kingdom | British | 151812860001 | |||||||||
| COATES, Richard John | Administrateur | Skipton House 80 London Road SE1 6LH London Community Health Partnerships United Kingdom | England | British | 215473490001 | |||||||||
| COX OBE, Sebert Leslie | Administrateur | Spurtop House Whitehall Lane DH8 7TA Iveston County Durham | England | British | 299375250001 | |||||||||
| DAY, Mark | Administrateur | Baltic Place South Shore Road NE8 3AE Gateshead 4th Floor West Tower England | England | British | 157242280001 | |||||||||
| FORDYCE, Alan Peter | Administrateur | Baltic Place South Shore Road NE8 3AE Gateshead 4th Floor West Tower England | Scotland | British | 97815240002 | |||||||||
| GARLAND, Peter Leslie | Administrateur | Curly Hill LS29 0DS Ilkley 140 West Yorkshire | United Kingdom | British | 101359640001 | |||||||||
| GATE, Andrew Mark | Administrateur | Baltic Place South Shore Road NE8 3AE Gateshead 4th Floor West Tower | Uk | British | 106320290001 | |||||||||
| GORDON, John Stephen | Administrateur | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| HILL, Adrian James | Administrateur | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House United Kingdom | United Kingdom | British | 323711220001 | |||||||||
| HOWELL, Colin | Administrateur | 53 Romney Close The Ings TS10 2JT Redcar Tyneside | British | 93579950001 | ||||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Administrateur | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Scotland | British | 53299620003 | |||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Administrateur | Baltic Place South Shore Road NE8 3AE Gateshead 4th Floor West Tower England | United Kingdom | British | 53299620002 | |||||||||
| KING, John James Edward | Administrateur | The Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House Scotland | United Kingdom | British | 202399790001 | |||||||||
| MCCORMICK, Neil St Clair | Administrateur | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House United Kingdom | Scotland | British | 197149390001 | |||||||||
| MCDONAGH, John | Administrateur | Aldersgate Street EC1A 4HD London 200 United Kingdom | United Kingdom | British | 182087330001 | |||||||||
| MCDOUGALL, Pamela | Administrateur | Manor Cottage 1 Front Street NE14 4HF Whickam Newcastle | British | 97815580001 | ||||||||||
| MCINTYRE, James | Administrateur | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House Stirlingshire Scotland | Scotland | British | 168656010001 | |||||||||
| PERCY, Michelle Frances | Administrateur | Civic Centre NE1 8QL Newcastle Upon Tyne Newcastle City Council United Kingdom | United Kingdom | British | 72426260003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NNT LIFT COMPANY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgin Lift Limited | 06 avr. 2016 | Exchange Tower, 11th Floor 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Resolis Limited Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Community Health Partnerships Limited | 06 avr. 2016 | Manchester One 53 Portland Street M1 3LD Manchester Suite 12b England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0