RENAISSANCE ENLIGHTENED BUILDING LIMITED

RENAISSANCE ENLIGHTENED BUILDING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRENAISSANCE ENLIGHTENED BUILDING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04966080
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RENAISSANCE ENLIGHTENED BUILDING LIMITED ?

    • Réparation de produits métalliques fabriqués (33110) / Industries manufacturières

    Où se situe RENAISSANCE ENLIGHTENED BUILDING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Greenfield Business Park No 2
    Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    Clwyd
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RENAISSANCE ENLIGHTENED BUILDING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SECKLOE 188 LIMITED17 nov. 200317 nov. 2003

    Quels sont les derniers comptes de RENAISSANCE ENLIGHTENED BUILDING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour RENAISSANCE ENLIGHTENED BUILDING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 déc. 2012

    État du capital au 03 déc. 2012

    • Capital: GBP 18,404.5
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Dermot Mulvihill en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Geoff Doherty en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    10 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    pages363(287)

    legacy

    3 pages288a

    Qui sont les dirigeants de RENAISSANCE ENLIGHTENED BUILDING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KINGSPAN GROUP LIMITED
    Greenfield Business Park No 2
    Bagillt Road, Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    Secrétaire
    Greenfield Business Park No 2
    Bagillt Road, Greenfield
    CH8 7GJ Holywell
    107980110001
    DOHERTY, Geoff Patrick
    Somerton
    Castleknock Golf Club, Porterstown Road
    Castleknock
    11
    Dublin 15
    Ireland
    Administrateur
    Somerton
    Castleknock Golf Club, Porterstown Road
    Castleknock
    11
    Dublin 15
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director161069960001
    MURTAGH, Gene
    Ballybarrack House
    Ardee Road
    IRISH Dundalk
    Co. Louth
    Ireland
    Administrateur
    Ballybarrack House
    Ardee Road
    IRISH Dundalk
    Co. Louth
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director66920570002
    EVANS, Martyn William
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    English78019510001
    ZANT BOER, Ian
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Garden Cottage
    Little Court
    NN12 8HE Farthingstone
    Northamptonshire
    British80009300004
    A.C. SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Secrétaire désigné
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900023470001
    EMW SECRETARIES LIMITED
    Seckloe House
    101 North 13th Street
    MK9 3NX Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Seckloe House
    101 North 13th Street
    MK9 3NX Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    93910510001
    AUSTEN, Patrick George
    15 Lakeside Drive
    KT10 9EZ Esher
    Surrey
    Administrateur
    15 Lakeside Drive
    KT10 9EZ Esher
    Surrey
    United KingdomBritishDirector55015730002
    BARNES, Graham Leslie
    104 Tressillian Road
    Brockley
    SE4 1XX London
    Administrateur
    104 Tressillian Road
    Brockley
    SE4 1XX London
    UkBritishNon Executive Director14145910002
    EVANS, Jonathan Leslie, Dr
    Covert View Cross Hayes
    Maker Lane
    DE13 8QR Hoar Cross
    Staffordshire
    Administrateur
    Covert View Cross Hayes
    Maker Lane
    DE13 8QR Hoar Cross
    Staffordshire
    BritishManaging Director42254810004
    EVANS, Martyn William
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    16 Paskin Close
    Fradley
    WS13 8NZ Lichfield
    Staffordshire
    EnglandEnglishDirector78019510001
    FELL, Nigel Anthony Russell
    Low Hall Pavilion
    Hackness Road Scalby
    YO13 0QY Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Low Hall Pavilion
    Hackness Road Scalby
    YO13 0QY Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector73837700002
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Administrateur
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director145024250001
    MURTAGH, Brendan
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    Administrateur
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    IrishDirector30924190002
    O'SULLIVAN, Patrick
    Carragoona,
    IRISH Bray Road
    Co. Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Carragoona,
    IRISH Bray Road
    Co. Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director116309670001
    SKIVINGTON, John
    25 Sandfield Terrace
    GU1 4LN Guildford
    Surrey
    Administrateur
    25 Sandfield Terrace
    GU1 4LN Guildford
    Surrey
    BritishMarketing Sales Director66957410001
    WOODLOCK, Henry
    14 Selborne Road
    Handsworth
    B20 2DW Birmingham
    Administrateur
    14 Selborne Road
    Handsworth
    B20 2DW Birmingham
    United KingdomBritishStructural Engineer95966360002
    A.C. DIRECTORS LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    900023460001
    EMW DIRECTORS LIMITED
    Seckloe House
    101 North 13th Street
    MK9 3NX Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Seckloe House
    101 North 13th Street
    MK9 3NX Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    97336730001

    RENAISSANCE ENLIGHTENED BUILDING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 09 déc. 2004
    Livré le 16 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 07 juin 2004
    Livré le 10 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All sums from time to time standing to the credit of an account in the name of the chargee including interest.
    Personnes ayant droit
    • Csam UK Put (No. 1) Limited and Csam UK Put (No. 2) Limited
    Transactions
    • 10 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 2004
    Livré le 10 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Renaissance Construction Systems Limited
    Transactions
    • 10 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 29 mars 2004
    Livré le 06 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 06 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0