SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED

SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05468022
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    14 Bankside
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    Tyne And Wear
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 08 juin 2018

    • Capital: GBP 501,000
    3 pagesSH01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2016

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 juin 2016

    État du capital au 09 juin 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 juin 2015

    État du capital au 12 juin 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    17 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juil. 2014

    État du capital au 01 juil. 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O C/O City & Northern Ltd Bankside 6 the Watermark Gateshead NE11 9SY England* le 01 juil. 2014

    1 pagesAD01

    Comptes établis au 31 mars 2013

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARK, Ian
    Bankside
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    14
    Tyne And Wear
    England
    Secrétaire
    Bankside
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    14
    Tyne And Wear
    England
    175954980001
    CANNON, Catherine Jane
    South Dissington Farm
    Ponteland
    NE18 0BN Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    South Dissington Farm
    Ponteland
    NE18 0BN Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish10677590001
    CLARK, Ian
    Bankside
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    14
    Tyne And Wear
    England
    Administrateur
    Bankside
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    14
    Tyne And Wear
    England
    ScotlandBritish168569590001
    ROBERTSON, William George
    Dun Donnachaidh
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Morayshire
    Administrateur
    Dun Donnachaidh
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Morayshire
    ScotlandBritish88810130001
    WARD, Elliott Allan
    Whiteside Grange
    Whalton
    NE61 3XQ Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    Whiteside Grange
    Whalton
    NE61 3XQ Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish94095750001
    BURLEY, Irene
    5 Upper Woodlands
    PH1 1DJ Perth
    Perthshire
    Secrétaire
    5 Upper Woodlands
    PH1 1DJ Perth
    Perthshire
    British100911750004
    MUTCH, Robert Gordon
    Altbeg
    Corsee Road
    AB31 5RT Banchory
    Kincardineshire
    Secrétaire
    Altbeg
    Corsee Road
    AB31 5RT Banchory
    Kincardineshire
    British282820002
    WILSON, Irene
    Upper Woodlands
    PH1 1DJ Perth
    5
    Scotland
    Secrétaire
    Upper Woodlands
    PH1 1DJ Perth
    5
    Scotland
    158257850001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Secrétaire
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    COWAN, Andrew David
    c/o C/O City & Northern Ltd
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    Bankside 6
    England
    Administrateur
    c/o C/O City & Northern Ltd
    The Watermark
    NE11 9SY Gateshead
    Bankside 6
    England
    Uk/EnglandBritish130905070001
    LYON, Steven
    44 Maule Street
    DD7 6AB Carnoustie
    Angus
    Administrateur
    44 Maule Street
    DD7 6AB Carnoustie
    Angus
    UkBritish97482510001
    WOODS, Kenneth James
    248 Mearns Road
    Newton Mearns
    G77 5LX Glasgow
    Administrateur
    248 Mearns Road
    Newton Mearns
    G77 5LX Glasgow
    British88972090002
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Lancashire
    60471930010

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr William George Robertson
    Perimeter Road
    IV30 6AE Elgin
    10
    Scotland
    06 avr. 2016
    Perimeter Road
    IV30 6AE Elgin
    10
    Scotland
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    SOUTH SHORE DEVELOPMENTS (MONKTON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 15 mars 2007
    Livré le 31 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The land and buildings at site BC2103/5 phase 1 monkton business park hebburn tyne and wear part l/h t/n TY453664. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 08 nov. 2006
    Livré le 23 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property being phase 1 monkton business park south mill lane hebburn tyne and wear t/n TY384504,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 juil. 2006
    Livré le 26 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over agreement
    Créé le 10 juil. 2006
    Livré le 26 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings being unit bc.2103/5 Phase 2 monkton business park hebburn tyne and wear the right title benefit and interest in the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0