CASTLEGAIT HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASTLEGAIT HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC038429
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASTLEGAIT HOMES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe CASTLEGAIT HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CASTLEGAIT HOMES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CASTLEGATE HOMES LIMITED08 oct. 200108 oct. 2001
    KILMARTIN HOMES LTD.20 déc. 199920 déc. 1999
    CHARLES GRAY (HOMES) LIMITED13 févr. 196313 févr. 1963

    Quels sont les derniers comptes de CASTLEGAIT HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour CASTLEGAIT HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2021 au 30 avr. 2021

    1 pagesAA01

    Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2021 au 30 juin 2021

    1 pagesAA01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2021

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Colin Edward Lewis en tant que directeur le 30 avr. 2021

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Colin Edward Lewis le 25 mars 2021

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 mai 2020

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Colin Edward Lewis le 02 juil. 2020

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 03 mai 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David Jonathan Knight en tant que directeur le 28 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 27 avr. 2018

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    legacy

    1 pagesAC93

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2016

    8 pagesAA

    Nomination de Mr David Jonathan Knight en tant qu'administrateur le 21 nov. 2016

    2 pagesAP01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Qui sont les dirigeants de CASTLEGAIT HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147809040001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    BLACK, Thelma
    Flat 20
    99 Strathmartine Rd
    DD3 7RY Dundee
    Secrétaire
    Flat 20
    99 Strathmartine Rd
    DD3 7RY Dundee
    British40275440001
    BLACK, Thelma
    Flat 20
    99 Strathmartine Rd
    DD3 7RY Dundee
    Secrétaire
    Flat 20
    99 Strathmartine Rd
    DD3 7RY Dundee
    British40275440001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    HASSAN, Brian
    33 Murray Street
    DD4 7JG Dundee
    Angus
    Secrétaire
    33 Murray Street
    DD4 7JG Dundee
    Angus
    Brittish1151560001
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    LEES, Gordon
    8 Grange Gardens
    Monifieth
    DD5 4NA Tayside
    Secrétaire
    8 Grange Gardens
    Monifieth
    DD5 4NA Tayside
    British82127910001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secrétaire
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    MCGUIRE, Hugh Keenan
    25 Ferry Road
    Monifieth
    DD5 4NS Dundee
    Angus
    Secrétaire
    25 Ferry Road
    Monifieth
    DD5 4NS Dundee
    Angus
    British544160001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secrétaire
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secrétaire
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    ROLLO STEVEN & BOND SOLICITORS
    21 Dock Street
    DD1 3DS Dundee
    Secrétaire
    21 Dock Street
    DD1 3DS Dundee
    871680002
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Administrateur
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritish91412650001
    BETHUNE, Hamish William
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    Administrateur
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    British1198020003
    BROWN, Andrew
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    5 Strathcarron Way
    PA2 7AE Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandScottish91209410001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    COOPER, James Arthur
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    British43500170001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    EDWARDS, David Reginald
    28 Linn Mill
    South Queensferry
    EH30 9ST Edinburgh
    West Lothian
    Administrateur
    28 Linn Mill
    South Queensferry
    EH30 9ST Edinburgh
    West Lothian
    British110601800001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    FRASER, Gordon Mackenzie
    Cortachy Cottage
    Auchterhouse
    Dundee
    Administrateur
    Cortachy Cottage
    Auchterhouse
    Dundee
    British16138750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GRAY, Robert Stirton
    506 Perth Road
    DD2 1LS Dundee
    Angus
    Administrateur
    506 Perth Road
    DD2 1LS Dundee
    Angus
    British544170001
    GRAY, Robert Stirton
    506 Perth Road
    DD2 1LS Dundee
    Angus
    Administrateur
    506 Perth Road
    DD2 1LS Dundee
    Angus
    British544170001
    GRAY, Robert Stirton
    Stonewell House
    Muirhead
    DD2 5QR Dundee
    Administrateur
    Stonewell House
    Muirhead
    DD2 5QR Dundee
    British39966980001
    HODGE, Barry George
    7 Dullatur Road
    G68 0AF Dullatur
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Dullatur Road
    G68 0AF Dullatur
    Lanarkshire
    United KingdomBritish102707890001
    KENNEDY, David Samuel
    1 Glebe Gardens
    EH12 7SG Edinburgh
    Administrateur
    1 Glebe Gardens
    EH12 7SG Edinburgh
    British93176930001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish102797820001
    KNIGHT, David Jonathan
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish190746580001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesWelsh59395180001
    MACCOLL, Stuart Neil
    47 Murieston Valley
    Murieston
    EH54 9HJ Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    47 Murieston Valley
    Murieston
    EH54 9HJ Livingston
    West Lothian
    ScotlandBritish111800560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASTLEGAIT HOMES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House 6 And 9
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House 6 And 9
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03215228
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CASTLEGAIT HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 04 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Former sub station site lying to the west of arkleston road, paisley.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mars 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 09 oct. 2003
    Livré le 14 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land adjacent to public road at balgowan, perthshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 oct. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 09 oct. 2003
    Livré le 14 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Part of balgowan sawmill and adjacent land at balgowan, perthshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 oct. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 25 sept. 2003
    Livré le 10 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at barshaw drive, paisley REN111616.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 oct. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 23 sept. 2003
    Livré le 01 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at old gartloch road, gartcosh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 oct. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 11 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2.1 hectares at arkleston road, paisley.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 16 juin 2003
    Livré le 27 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.418 acres at calderpark zoo, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 06 déc. 2002
    Livré le 12 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The tinto firs hotel and ground attached at 470-472 kilmarnock road, newlands, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 19 août 2002
    Livré le 22 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    20-28 (even numbers) robertson street, glasgow and 13-33 (odd numbers) and 39 and 41 oswald street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 août 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Assignation of standard security
    Créé le 19 août 2002
    Livré le 22 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In security of the obligations contained within the missives dated 8 and 9 august 2002
    Brèves mentions
    45/51 oswald street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 août 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 19 août 2002
    Livré le 22 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of condition 14 of the agreement constituted by missives dated 8 and 9 august 2002
    Brèves mentions
    20, 22, 24, 26 and 28 robertson street, glasgow 13 to 33 (odd numbers) and 39 oswald street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Ppg Metro Oswald Limited
    Transactions
    • 22 août 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 2002
    Livré le 15 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.125 hectares at balmullo,fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 01 juil. 2002
    Livré le 10 juil. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond dated 24 june 2002
    Brèves mentions
    Former limb fitting centre, queen street, broughty ferry, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juil. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 30 avr. 2002
    Livré le 13 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond dated 21 march 2002
    Brèves mentions
    Land at east kirkton, arbroath (title numbers ANG9112 & ANG10451).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 sept. 2001
    Livré le 08 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 oct. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 11 sept. 2000
    Livré le 15 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground to the north side of south william street, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 juil. 1999
    Livré le 30 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground at reform street and lying to the west of craig lane, tayport.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 juil. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 1999
    Livré le 05 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground in anstruther, fife lying to east of waid academy sports field.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 mai 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 13 mai 1998
    Livré le 27 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.7174 hectares of ground at spearshill road,tayport,fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 mai 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 juin 1996
    Livré le 27 juin 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.050 hectares of land at crail road, anstruther, fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juin 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 oct. 1995
    Livré le 31 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ogilvie road,broughty ferry,dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 oct. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 mai 1995
    Livré le 14 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £206,250
    Brèves mentions
    The site of the former dunella hotel, albany road, broughty ferry, dundee.
    Personnes ayant droit
    • Trojan Metals Limited
    Transactions
    • 14 juin 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 mai 1995
    Livré le 06 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Dunella hotel,albany road,broughty ferry,dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 juin 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0