Michelle Hunter MOTION
Personne physique
Titre | Mrs |
---|---|
Prénom | Michelle |
Deuxième prénom | Hunter |
Nom de famille | MOTION |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 60 |
Total | 63 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALKER GROUP (LAND & PROJECTS) LIMITED | 31 janv. 2019 | Dissoute | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British | |
PERTEN LIMITED | 31 janv. 2019 | Dissoute | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British | |
DAWN HOMES (JOHNSTONE) LIMITED | 24 mai 2018 | Dissoute | Management Accountant | Administrateur | West George Street G2 2PG Glasgow 220 United Kingdom | United Kingdom | British | |
SPRINGFIELD M&M HOMES LIMITED | 03 mai 2022 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire United Kingdom | United Kingdom | British |
TULLOCH HOMES GROUP LIMITED | 01 déc. 2021 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
TULLOCH LIMITED | 01 déc. 2021 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
TULLOCH HOMES (DRUMOSSIE) LIMITED | 01 déc. 2021 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
TULLOCH HOMES LTD. | 01 déc. 2021 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
TULLOCH HOMES EXPRESS LIMITED | 01 déc. 2021 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
ARGYLL HOMES (HAMILTON) LIMITED | 01 déc. 2021 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
ARGYLL DEVELOPMENTS (SCOTLAND) LIMITED | 01 déc. 2021 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
TULLOCH HOMES HOLDINGS LIMITED | 01 déc. 2021 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
GLASSGREEN HIRE LIMITED | 18 août 2020 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
WALKER GROUP DEVELOPMENTS LIMITED | 31 janv. 2019 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
WALKER GROUP SPRINGFIELD HOLDINGS LIMITED | 31 janv. 2019 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
WALKER GROUP (SCOTLAND) LIMITED | 31 janv. 2019 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
DAWN HOMES HOLDINGS LIMITED | 02 mai 2018 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House, 8 Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
SPRINGFIELD PROPERTIES PLC | 31 janv. 2014 | 10 mars 2023 | Active | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
WALKER RESIDENTIAL (SCOTLAND) LIMITED | 31 janv. 2019 | 10 mars 2023 | Dissoute | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
WALKER CONTRACTS (SCOTLAND) LIMITED | 31 janv. 2019 | 10 mars 2023 | Dissoute | Management Accountant | Administrateur | 8 Southfield Drive IV30 6GR Elgin Alexander Fleming House Morayshire Scotland | United Kingdom | British |
AVANT HOMES (SCOTLAND MK) LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Active | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
AVANT HOMES (SCOTLAND MK) LIMITED | 01 oct. 2007 | 18 août 2009 | Active | Accountant | Administrateur | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | United Kingdom | British |
MANOR KINGDOM SOUTHERN LTD | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
NIMBUS STYLE LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
ST ANDREW LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
KINGDOM PROPERTY GROUP (GLASGOW) LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
MANOR KINGDOM ESTATES LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
HOMES WITH FLAIR LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
ST. ANDREWS HOMES SCOTLAND LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
MANOR KINGDOM FINANCE INVESTMENTS LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
MANOR KINGDOM HOLDINGS LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
MANOR KINGDOM DEVELOPMENTS LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
GLADEDALE TIMBER SYSTEMS LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
MANOR KINGDOM INVESTMENTS LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | |
MK TIMBER KITS LIMITED | 30 avr. 2008 | 18 août 2009 | Dissoute | Director | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0