BABTIE INTERNATIONAL LIMITED

BABTIE INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBABTIE INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC062616
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BABTIE INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Autres activités d'ingénierie (71129) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BABTIE INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7HX
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BABTIE INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BABTIE SHAW & MORTON INTERNATIONAL LIMITED29 juin 197729 juin 1977

    Quels sont les derniers comptes de BABTIE INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BABTIE INTERNATIONAL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BABTIE INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 mars 2016

    État du capital au 17 mars 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Michael Sean Udovic en tant que secrétaire le 01 sept. 2015

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 mars 2015

    État du capital au 17 mars 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mars 2014

    État du capital au 28 mars 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael Timothy Norris le 24 mars 2014

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Leon Anthony Power le 24 mars 2014

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2013

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    15 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Michael Higgins en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael Sean Udovic en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de William Markley en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    14 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    17 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2008

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BABTIE INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NORRIS, Michael Timothy
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7HX
    Secrétaire
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7HX
    British52563600002
    POWER, Leon Anthony
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7HX
    Administrateur
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7HX
    IrelandIrish126002790001
    MARKLEY, William Clyde
    2105
    Sunnybank Drive
    FOREIGN La Canada
    Flintridge 91011
    California
    Secrétaire
    2105
    Sunnybank Drive
    FOREIGN La Canada
    Flintridge 91011
    California
    British110425220001
    UDOVIC, Michael Sean
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7HX
    Secrétaire
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7HX
    163543120001
    BABTIE SHAW & MORTON
    95 Bothwell Street
    G2 7HX Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    95 Bothwell Street
    G2 7HX Glasgow
    Lanarkshire
    35578630001
    JACOBS U.K. LIMITED
    95 Bothwell Street
    G2 7HX Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    Secrétaire
    95 Bothwell Street
    G2 7HX Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    31551250002
    ANGUS, Ronald Macdonald
    6 Duchess Park
    G84 9PY Helensburgh
    Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    6 Duchess Park
    G84 9PY Helensburgh
    Dunbartonshire
    Scotland
    British35578730001
    ARTHUR, George Alexander Franklin
    29 North Erskine Park
    Bearsden
    G61 4LY Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    29 North Erskine Park
    Bearsden
    G61 4LY Glasgow
    Lanarkshire
    British452720001
    ATKINS, John Phillippo
    Kingstanding House
    Westfield Rd
    OX10 9JW Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Kingstanding House
    Westfield Rd
    OX10 9JW Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish46326370001
    BAIRD, David
    40 Copper Beech Wynd
    Cairneyhill
    KY12 8UP Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    40 Copper Beech Wynd
    Cairneyhill
    KY12 8UP Dunfermline
    Fife
    Great BritainBritish111031360001
    BANKS, David James
    69 Partickhill Road
    G11 5AD Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    69 Partickhill Road
    G11 5AD Glasgow
    Strathclyde
    British289550001
    BARR, Robert Ross
    10 Wardlaw Road
    Bearsden
    G61 1AL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    10 Wardlaw Road
    Bearsden
    G61 1AL Glasgow
    Lanarkshire
    British41876070004
    BERRY, Norman Stevenson Mclean
    2 Fintry Gardens
    G61 4RJ Glasgow
    Administrateur
    2 Fintry Gardens
    G61 4RJ Glasgow
    ScotlandBritish80509260001
    BOOTH, Geoffrey
    1 Pendragon
    Lister Lane
    BD2 4LT Bradford
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Pendragon
    Lister Lane
    BD2 4LT Bradford
    West Yorkshire
    British493490001
    BROADFOOT, William John Cameron
    43 Viewpark Drive, Burnside
    Rutherglen
    G73 3QE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    43 Viewpark Drive, Burnside
    Rutherglen
    G73 3QE Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish118078890001
    CARTER, Paul Gilbert
    Woodlyn
    High Branton
    G65 0RA Kilsyth
    Administrateur
    Woodlyn
    High Branton
    G65 0RA Kilsyth
    British493470001
    CLARKE, Robert Hugh
    7 Grange Close
    Goring On Thames
    RG8 9DY Reading
    Administrateur
    7 Grange Close
    Goring On Thames
    RG8 9DY Reading
    British34016390001
    COLWILL, Stuart William
    2 Commonside
    KT18 7HT Epsom
    Surrey
    Administrateur
    2 Commonside
    KT18 7HT Epsom
    Surrey
    British66478420002
    COLWILL, Stuart William
    74 Swindon Lane
    GL50 4PA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    74 Swindon Lane
    GL50 4PA Cheltenham
    Gloucestershire
    British66478420001
    CRAIG, Alan Harcourt
    31 Broomley Drive
    Giffnock
    G46 6PD Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    31 Broomley Drive
    Giffnock
    G46 6PD Glasgow
    Strathclyde
    British17991630001
    CUBITT, Mark
    Duncraggan House
    34 Airthrey Road
    FK9 5JS Stirling
    Administrateur
    Duncraggan House
    34 Airthrey Road
    FK9 5JS Stirling
    ScotlandBritish64309900002
    DUFF, Robert Shepherd
    Graham Avenue
    G74 4JZ East Kilbride
    10
    Scotland
    Administrateur
    Graham Avenue
    G74 4JZ East Kilbride
    10
    Scotland
    ScotlandBritish165632810001
    DURNING, Bruce Alexander
    52 Larchfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    52 Larchfield Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QN Glasgow
    Lanarkshire
    British509080001
    FAWCETT, David Fred
    7 Mole House
    Court Mount Road
    GU27 2PR Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    7 Mole House
    Court Mount Road
    GU27 2PR Haslemere
    Surrey
    British31551220003
    HIGGINS, Michael John
    The Coach House
    5a Cleveden Road, Kelvinside
    G12 0NT Glasgow
    Administrateur
    The Coach House
    5a Cleveden Road, Kelvinside
    G12 0NT Glasgow
    ScotlandUnited States118078620001
    JOHNSTON, David Robert
    35 Eagle Crescent
    Bearsden
    G61 4HP Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    35 Eagle Crescent
    Bearsden
    G61 4HP Glasgow
    Lanarkshire
    British67876850001
    JOHNSTON, Thomas Alan
    2 Westbourne Drive
    Bearsden
    G61 4BD Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    2 Westbourne Drive
    Bearsden
    G61 4BD Glasgow
    Strathclyde
    British525310001
    KENNARD, Robert Moir, Dr
    4b Dor Fook Mansion
    126 Pokfulam Road
    Pokfulam
    Hong Kong
    Administrateur
    4b Dor Fook Mansion
    126 Pokfulam Road
    Pokfulam
    Hong Kong
    British12686160001
    KINDER, Graham
    Winbourne
    2a Cairndhu Avenue
    G84 8PW Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Winbourne
    2a Cairndhu Avenue
    G84 8PW Helensburgh
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish493480001
    LINDSAY, Cameron Stuart
    16 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HE Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    16 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HE Solihull
    West Midlands
    British41771790001
    MACDONALD, Alexander
    20 Balmoral Drive
    PA7 5HR Bishopton
    Renfrewshire
    Administrateur
    20 Balmoral Drive
    PA7 5HR Bishopton
    Renfrewshire
    British31551210002
    MASTERTON, Gordon Grier Thomson
    Montrose Terrace
    PA11 3DN Bridge Of Weir
    Corrievreck
    Renfrewshire
    Administrateur
    Montrose Terrace
    PA11 3DN Bridge Of Weir
    Corrievreck
    Renfrewshire
    ScotlandBritish136933130001
    MILLMORE, James Peter
    7 High Standing
    Chaldon Common Road, Chaldon
    CR3 5DY Caterham
    Surrey
    Administrateur
    7 High Standing
    Chaldon Common Road, Chaldon
    CR3 5DY Caterham
    Surrey
    United KingdomBritish493510003
    MITCHELL, William Gilchrist
    1 Henderland Drive
    Henderland Gate
    G61 1JJ Glasgow
    Administrateur
    1 Henderland Drive
    Henderland Gate
    G61 1JJ Glasgow
    British6248520002
    MURRAY, Morris James
    2 Peveril Avenue
    Burnside Rutherglen
    G73 4RD Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    2 Peveril Avenue
    Burnside Rutherglen
    G73 4RD Glasgow
    Strathclyde
    British17991640001

    BABTIE INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 01 juin 1999
    Livré le 07 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 juin 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0