FORTH STEEL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFORTH STEEL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC073563
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FORTH STEEL LIMITED ?

    • Commerce de gros de métaux et minerais métalliques (46720) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe FORTH STEEL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    26 Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FORTH STEEL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour FORTH STEEL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination de Mr Gerard Robert Gurney en tant qu'administrateur le 03 juil. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Samuel William Peter Collard en tant que directeur le 03 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2019 au 30 juin 2020

    1 pagesAA01

    État du capital au 16 juin 2020

    • Capital: GBP 1.00
    6 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Graeme Everitt Hill en tant que directeur le 30 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Barrie Lawson en tant que directeur le 07 mars 2017

    2 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 janv. 2016

    État du capital au 28 janv. 2016

    • Capital: GBP 1,161,514
    SH01

    Qui sont les dirigeants de FORTH STEEL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GURNEY, Gerard Robert
    Scholar Green Road
    Stretford
    M32 0TR Manchester
    Lamba House
    England
    Administrateur
    Scholar Green Road
    Stretford
    M32 0TR Manchester
    Lamba House
    England
    EnglandBritishDirector271611730001
    MURRAY, David Edward, Sir
    Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    26
    Scotland
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    26
    Scotland
    ScotlandBritishMetal Trader34535230001
    GRASSICK, Gordon Mckenzie
    5 The Green
    EH14 7LD Balerno
    Midlothian
    Secrétaire
    5 The Green
    EH14 7LD Balerno
    Midlothian
    British826490002
    HORNE, David William Murray
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Secrétaire
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    British41593900004
    TAHIR, Sarah
    13 Marchmont Street
    EH9 1EL Edinburgh
    Secrétaire
    13 Marchmont Street
    EH9 1EL Edinburgh
    British38346270001
    COCKBURN, Kenneth Andrew
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    Administrateur
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    ScotlandBritishCommercial Director835820002
    COLLARD, Samuel William Peter
    Cobra Court
    Brightgate Way, Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cobra Court
    Brightgate Way, Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Director168943730001
    GRASSICK, Gordon Mckenzie
    5 The Green
    EH14 7LD Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    5 The Green
    EH14 7LD Balerno
    Midlothian
    BritishChartered Accountant826490002
    HEGARTY, Thomas Gerard
    22 Christiemiller Avenue
    EH7 6ST Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    22 Christiemiller Avenue
    EH7 6ST Edinburgh
    Midlothian
    BritishTransport Manager827360001
    HILL, Graeme Everitt
    Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    26
    Scotland
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    26
    Scotland
    EnglandBritishDirector144984260001
    HORNE, David William Murray
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor41593900002
    LAWSON, David Barrie
    Cobra Court
    Brightgate Way, Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cobra Court
    Brightgate Way, Trafford Park
    M32 0TB Manchester
    Brightgate House
    United Kingdom
    EnglandBritishOperations Director122575270001
    MCGILL, Michael Scott
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    ScotlandBritishFinance Director99070570001
    TOULOUSE, Neil Finlay
    182 Newbattle Abbey Crescent
    Newbattle
    EH22 3LT Dalkeith
    Midlothian
    Administrateur
    182 Newbattle Abbey Crescent
    Newbattle
    EH22 3LT Dalkeith
    Midlothian
    BritishMetal Trader31116830001
    VINE, Harry Michael
    9 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DR
    Administrateur
    9 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DR
    ScotlandBritishMetal Trader827350002
    WILSON, James Donald Gilmour
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    ScotlandBritishGroup Chief Executive69298770001
    WILSON, James Donald Gilmour
    12 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    12 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishAccountant69298770001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FORTH STEEL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Murray Metals Ltd
    Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    26
    Scotland
    06 avr. 2016
    Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    26
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementScottish Registry
    Numéro d'enregistrementSc417296
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    FORTH STEEL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 22 mai 2012
    Livré le 01 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    28 south gyle crescent, edinburgh MID23711.
    Personnes ayant droit
    • Pnc Business Credit
    Transactions
    • 01 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 23 sept. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 12 mai 2012
    Livré le 22 mai 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Pnc Business Credit
    Transactions
    • 22 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 24 mai 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 sept. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 12 mai 2012
    Livré le 22 mai 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Pnc Business Credit
    Transactions
    • 22 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 24 mai 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 sept. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 20 avr. 2010
    Livré le 04 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 30 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 25 juin 2002
    Livré le 27 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    28 south gyle crescent, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juin 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Letter of offset
    Créé le 11 janv. 1988
    Livré le 14 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by murray international holdings LTD
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 29 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of offset
    Créé le 07 févr. 1986
    Livré le 25 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by premier alloys LTD and/or another
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 29 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 07 sept. 1984
    Livré le 13 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • 30 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Letter of offset
    Créé le 28 août 1984
    Livré le 13 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by northern surplus steel stocks LTD & another
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of forth steel LTD.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • 29 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of offset
    Créé le 07 oct. 1983
    Livré le 20 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by nuclear medical electronic systems & services LTD and/or others
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of forth steel LTD.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 oct. 1983Enregistrement d'une charge
    • 29 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 02 août 1982
    Livré le 12 août 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 août 1982Enregistrement d'une charge
    • 07 avr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of offset
    Créé le 21 juil. 1982
    Livré le 30 juil. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by murray international holdings LTD &/or others
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 juil. 1982Enregistrement d'une charge
    • 29 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0