PERTEN LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPERTEN LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC097437
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PERTEN LIMITED ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction

    Où se situe PERTEN LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Alexander Fleming House
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Morayshire
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PERTEN LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour PERTEN LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mai 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge SC0974370011, créée le 31 janv. 2019

    17 pagesMR01

    Nomination de Andrew Todd en tant que secrétaire le 31 janv. 2019

    2 pagesAP03

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 sept. 2019 au 31 mai 2019

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de as Company Services Limited en tant que secrétaire le 31 janv. 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Bruce Edward Walker en tant que directeur le 31 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 1 Rutland Court Edinburgh EH3 8EY à Alexander Fleming House 8 Southfield Drive Elgin Morayshire IV30 6GR le 07 févr. 2019

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de David Gunderson en tant que directeur le 31 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edward Michael Walker en tant que directeur le 31 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Michelle Hunter Motion en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Innes Smith en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Alexander William Adam en tant qu'administrateur le 31 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Bruce Edward Walker en tant qu'administrateur le 18 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Gunderson en tant qu'administrateur le 18 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2018

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Edward Michael Walker le 12 janv. 2018

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2017

    8 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de PERTEN LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TODD, Andrew
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Secrétaire
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    255111560001
    ADAM, Alexander William
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Administrateur
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    United KingdomBritishChairman246070480002
    MOTION, Michelle Hunter
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Administrateur
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    United KingdomBritishManagement Accountant78545300002
    SMITH, Innes
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    Administrateur
    8 Southfield Drive
    IV30 6GR Elgin
    Alexander Fleming House
    Morayshire
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant78090970005
    AS COMPANY SERVICES LIMITED
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Secrétaire
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC316974
    119906300001
    BELL & SCOTT (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED
    Hill Street
    EH2 3LD Edinburgh
    16
    Midlothian
    Scotland
    Secrétaire
    Hill Street
    EH2 3LD Edinburgh
    16
    Midlothian
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC268061
    97847080001
    BELL & SCOTTS
    16 Hill Street
    EH2 3LD Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    16 Hill Street
    EH2 3LD Edinburgh
    Midlothian
    66108740002
    GUNDERSON, David
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    ScotlandBritishDirector/Accountant44226160001
    MURRAY, Randolph Stuart
    20 Avonmill View
    Linlithgow Bridge
    EH49 7SH Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    20 Avonmill View
    Linlithgow Bridge
    EH49 7SH Linlithgow
    West Lothian
    United KingdomBritishCompany Director39965330001
    RATHBONE, Kevin
    4 St Mungos View
    EH26 8JA Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    4 St Mungos View
    EH26 8JA Penicuik
    Midlothian
    BritishCompany Director13920001
    SMITH, James Ian Hay
    16 Hill Street
    EH2 3LD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    16 Hill Street
    EH2 3LD Edinburgh
    Midlothian
    BritishWriter To The Signet57380001
    WALKER, Bruce Edward
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    ScotlandBritishDirector228615130001
    WALKER, Edward Michael
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director1388520006
    WARDROP, Alexander Duncan
    9 The Glebe
    EH49 6SG Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    9 The Glebe
    EH49 6SG Linlithgow
    West Lothian
    BritishFinancial Director966110004

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PERTEN LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Walker Holdings Scotland Ltd
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    06 avr. 2016
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleScots Law
    Lieu d'enregistrementUk Companies Register
    Numéro d'enregistrementSc146690
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PERTEN LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 31 janv. 2019
    Livré le 11 févr. 2019
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 févr. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    Standard security
    Créé le 30 juil. 1993
    Livré le 09 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to one hectare and 92 decimal at north berwick.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 09 août 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 19 juin 1992
    Livré le 08 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    10.2 acres at strowan road, comrie.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 08 juil. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 18 juin 1992
    Livré le 08 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5.62 acres at markinch, fife.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 08 juil. 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juil. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 12 mai 1988
    Livré le 02 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 déc. 1986
    Livré le 12 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9.075 acres lying in the united parishes of fossoway and tullibole, county of kinross.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    • 08 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 déc. 1986
    Livré le 12 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5.62 acres at markinch, fife.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    • 08 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 04 déc. 1986
    Livré le 12 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and whole that piece of ground part of the lands of westerton, logie.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 17 juin 1986
    Livré le 24 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 juin 1986Enregistrement d'une charge
    Letter of offset
    Créé le 17 juin 1986
    Livré le 24 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 18 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0