STRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED

STRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC108665
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe STRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    50 Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ZORRO LIMITED13 janv. 198813 janv. 1988

    Quels sont les derniers comptes de STRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 juil. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 avr. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour STRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au28 août 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation11 sept. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au28 août 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour STRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 28 août 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2024

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Gillian Elizabeth Mary Dunion Obe le 31 déc. 2024

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Tim Robert Faehnrich en tant qu'administrateur le 31 janv. 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 28 août 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2023

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 août 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2022

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Steven David James Wallace en tant que directeur le 19 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Gillian Elizabeth Mary Dunion Obe en tant qu'administrateur le 19 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Olga Vladimirovna Kozlova en tant que directeur le 17 mars 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan John Feighery en tant que directeur le 06 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 août 2022 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2022 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    7 pagesMA

    Cessation de la nomination de Alison Mary Brown Morrison en tant que directeur le 04 mai 2022

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2021

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2020

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de University of Strathclyde en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 déc. 2019

    2 pagesPSC02

    Cessation de Gillian Macaulay en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 déc. 2019

    1 pagesPSC07

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2019

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de Gillian Anne Macaulay en tant que directeur le 05 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de STRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUNION CBE, Gillian Elizabeth Mary
    George Street
    G1 1XW Glasgow
    210b, Royal College Building
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    G1 1XW Glasgow
    210b, Royal College Building
    Scotland
    ScotlandBritish311470540002
    FAEHNRICH, Tim Robert
    Richmond Street
    G1 1XQ Glasgow
    16
    Scotland
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XQ Glasgow
    16
    Scotland
    United KingdomGerman331835290001
    FLINT, David
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Secrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British900000220001
    MACAULAY, Gillian Anne
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Secrétaire
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    British48775060002
    WEIR, George Bonnar
    6 Kirkdene Crescent
    Newton Mearns
    G77 5RP Glasgow
    Secrétaire
    6 Kirkdene Crescent
    Newton Mearns
    G77 5RP Glasgow
    British33682590001
    MACROBERTS (SOLICITORS)
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Secrétaire
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    717590001
    ARMSTRONG, Robert Peter
    South Riding
    PA13 4BA Kilmacolm
    Administrateur
    South Riding
    PA13 4BA Kilmacolm
    British870140001
    CAMPBELL, Craig Lyon
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    ScotlandScottish64912330004
    CHRYSTIE, Kenneth George, Dr
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    ScotlandBritish70280001
    COYLE, David
    9 Atholl Gardens
    Bearsden
    G61 3JT Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    9 Atholl Gardens
    Bearsden
    G61 3JT Glasgow
    Lanarkshire
    British5074120001
    DICKSON, Ian
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Administrateur désigné
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    ScotlandBritish900000230001
    FEIGHERY, Alan John, Dr
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    ScotlandBritish265030400001
    FLINT, David
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Administrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British900000220001
    KOZLOVA, Olga Vladimirovna
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    Graham Hills Building
    Scotland
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    Graham Hills Building
    Scotland
    United KingdomBritish261286740001
    MACAULAY, Gillian Anne
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    ScotlandBritish48775060002
    MACGARVIE, Derek
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    United KingdomBritish183578850001
    MACLENNAN, Gordon
    15 Gibson Road
    PA4 0RH Renfrew
    Renfrewshire
    Administrateur
    15 Gibson Road
    PA4 0RH Renfrew
    Renfrewshire
    ScotlandBritish15514720001
    MCGARRY, Margaret
    8 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Administrateur
    8 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    ScotlandBritish34789910002
    MCLAREN-ROBERTSON, Yvonne Elizabeth
    4 The Stables
    Mugdock
    G62 8LQ Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    4 The Stables
    Mugdock
    G62 8LQ Glasgow
    Strathclyde
    British86244190001
    MCWILLIAMS, Gordon Nicol
    16 Westgate
    Mid Calder
    EH53 0SP Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    16 Westgate
    Mid Calder
    EH53 0SP Livingston
    West Lothian
    British26300790001
    MILLER, William Brown
    Whiteleys
    Alloway
    KA7 4EG Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    Whiteleys
    Alloway
    KA7 4EG Ayr
    Ayrshire
    ScotlandBritish30221770001
    MILLER, William Brown
    Whiteleys
    Alloway
    KA7 4EG Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    Whiteleys
    Alloway
    KA7 4EG Ayr
    Ayrshire
    ScotlandBritish30221770001
    MINTY, Alistair Forbes
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    ScotlandBritish86601910001
    MORRIS, Richard Mowat
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    ScotlandBritish62120001
    MORRISON, Alison Mary Brown
    St. James Road
    G4 0NT Glasgow
    181
    Scotland
    Administrateur
    St. James Road
    G4 0NT Glasgow
    181
    Scotland
    United KingdomBritish121958520001
    MURGITROYD, Ian George
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    ScotlandBritish184070003
    OSWALD, Robert Rae
    54 Strathmore Avenue
    PA1 3EE Paisley
    Strathclyde
    Administrateur
    54 Strathmore Avenue
    PA1 3EE Paisley
    Strathclyde
    British56096740001
    STIRLING, Alfred Patrick
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    United KingdomBritish6373230001
    THOMSON, Hugh Gilmour
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    Administrateur
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    50
    ScotlandBritish121113780001
    WALLACE, Steven David James
    George Street
    G1 1XW Glasgow
    204 Royal College Building, George St
    Scotland
    Administrateur
    George Street
    G1 1XW Glasgow
    204 Royal College Building, George St
    Scotland
    ScotlandBritish264256150001
    WEIR, George Bonnar
    6 Kirkdene Crescent
    Newton Mearns
    G77 5RP Glasgow
    Administrateur
    6 Kirkdene Crescent
    Newton Mearns
    G77 5RP Glasgow
    ScotlandBritish33682590001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STRATHCLYDE UNIVERSITY INCUBATOR LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    University Of Strathclyde
    Richmond Street
    G1 1XQ Glasgow
    16
    Scotland
    05 déc. 2019
    Richmond Street
    G1 1XQ Glasgow
    16
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueCharity
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies Hosuse Edinburgh
    Numéro d'enregistrementSc015263
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Gillian Macaulay
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    Graham Hills Building
    Scotland
    06 avr. 2016
    Richmond Street
    G1 1XP Glasgow
    Graham Hills Building
    Scotland
    Oui
    Forme juridiqueDirector
    Autorité légaleUk
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0