TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED

TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC121614
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?

    • Autres activités de télécommunications (61900) / Information et communication

    Où se situe TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SCOTCABLE (CUMBERNAULD) LIMITED 01 oct. 199001 oct. 1990
    CABLE NORTH (CUMBERNAULD) LIMITED21 déc. 198921 déc. 1989
    NEBBICH LIMITED27 nov. 198927 nov. 1989

    Quels sont les derniers comptes de TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    7 pagesLIQ13(Scot)

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 1 South Glye Crescent Lane Edinburgh EH3 8EX

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 1 South Glye Crescent Lane Edinburgh EH3 8EX

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG à Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX le 14 mai 2018

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 02 mai 2018

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2016

    19 pagesAA

    legacy

    80 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Notification de General Cable Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 juil. 2017

    2 pagesPSC02

    Cessation de Telewest Communications (Scotland Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 juil. 2017

    1 pagesPSC07

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    État du capital au 08 mai 2017

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge SC1216140014 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1216140008 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1216140009 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1216140011 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1216140016 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1216140015 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMES, Gillian Elizabeth
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Secrétaire
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    151396090001
    DUNN, Robert Dominic
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Administrateur
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    EnglandBritish182167230001
    BROADEST, Guy David
    Tile House
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Secrétaire
    Tile House
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    British96454660001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    FLINT, David
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Secrétaire
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British35387900001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Secrétaire
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Secrétaire
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    MOORE, Brian
    44 The Little Boltons
    SW10 9LL London
    Secrétaire
    44 The Little Boltons
    SW10 9LL London
    British33419000002
    SHEPHERD & WEDDERBURN
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2ET Edinburgh
    Secrétaire désigné
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2ET Edinburgh
    900030690001
    THORNTONS WS
    50 Castle Street
    DD1 3RU Dundee
    Tayside
    Secrétaire désigné
    50 Castle Street
    DD1 3RU Dundee
    Tayside
    900003090001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Secrétaire
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BAMBROUGH, Noel Raymond
    25 St. Edmund's Drive
    M4N 2P7 Toronto
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    25 St. Edmund's Drive
    M4N 2P7 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian1171450002
    BRYAN, Danny Frank
    The Marble Suite
    The Mansion Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    Administrateur
    The Marble Suite
    The Mansion Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    American41071470001
    BRYSON, Gary Spath
    5132 South Hanover Street
    80111 Englewood
    Colorado
    Usa
    Administrateur
    5132 South Hanover Street
    80111 Englewood
    Colorado
    Usa
    American36182070001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Administrateur
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    CARLETON, Lawrence James
    The Marble Suite
    The Mansion
    KT16 0QG Ottershaw Park
    Ottershaw Surrey
    Administrateur
    The Marble Suite
    The Mansion
    KT16 0QG Ottershaw Park
    Ottershaw Surrey
    American36182000001
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Administrateur
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    DAVIDSON, Stephen James
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92784240001
    DICKSON, Ian
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Administrateur désigné
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    ScotlandBritish900000230001
    FLINT, David
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Administrateur
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British35387900001
    GALE, Robert Charles
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Administrateur
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    EnglandBritish96956740001
    GRAHAM, David Robert
    65 Clabon Mews
    Cadogan Square
    SW1X 0EQ London
    Administrateur
    65 Clabon Mews
    Cadogan Square
    SW1X 0EQ London
    Canadian38492860002
    HAMACHEK, Ross Frank
    5011 Sedgwick Street
    20016 Nw Washington Dc
    Usa 20016
    Administrateur
    5011 Sedgwick Street
    20016 Nw Washington Dc
    Usa 20016
    American4948230001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Administrateur
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MICHELS, Alan
    Catalina Abbotswood Drive
    St Georges Hill
    KT13 0LT Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Catalina Abbotswood Drive
    St Georges Hill
    KT13 0LT Weybridge
    Surrey
    British43658810001
    MORSE, John Burke
    7906 Old Cedar Court
    Mclean
    Virginia 22102
    Usa
    Administrateur
    7906 Old Cedar Court
    Mclean
    Virginia 22102
    Usa
    American32758880001
    REXROTH, Lynn Charles
    St Anton Woodlands Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    St Anton Woodlands Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    American49075080001
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Administrateur
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Administrateur
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    Administrateur
    1 South Gyle Crescent Lane
    Edinburgh
    EH12 9EG
    United KingdomBritish164134250001
    VAN VALKENBURG, David Raynor
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Administrateur
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    American53941940001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    04 juil. 2017
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4925679
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    South Gyle Crescent Lane
    EH12 9EG Edinburgh
    1
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    South Gyle Crescent Lane
    EH12 9EG Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc150058
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 21 mars 2017
    Livré le 23 mars 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 23 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 févr. 2017
    Livré le 07 févr. 2017
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transactions
    • 07 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 26 avr. 2016
    Livré le 27 avr. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 27 avr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 avr. 2015
    Livré le 07 mai 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 07 mai 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 mars 2015
    Livré le 02 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 02 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 janv. 2015
    Livré le 06 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 06 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 04 avr. 2014
    Livré le 10 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 10 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 mars 2014
    Livré le 02 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag London Branch
    Transactions
    • 02 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 juin 2013
    Livré le 18 juin 2013
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 18 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Confirmation deed
    Créé le 03 mars 2011
    Livré le 21 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Pursuant to clause 12 of the group intercreditor agreement the new notes were hereby designated (see form MG01S).
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 21 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite debenture
    Créé le 10 juin 2010
    Livré le 23 juin 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 23 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 23 juin 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 mai 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 26 sept. 1998
    Livré le 13 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Toronto-Dominion Bank as Security Trustee
    Transactions
    • 13 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 24 juil. 1996
    Livré le 09 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges on various assets....... See ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cibc Wood Gundy PLC as Security Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 09 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 24 juil. 1996
    Livré le 08 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    All property etc....... see ch microfiche for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cibc Wood Gundy PLC as Security Trustee for Itself and Others
    Transactions
    • 08 août 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 13 juin 1994
    Livré le 27 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by the company and others
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge see ch microfiche.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Security Trustee
    Transactions
    • 27 juin 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 13 juin 1994
    Livré le 27 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Security Trustee
    Transactions
    • 27 juin 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 mai 2018Commencement of winding up
    10 août 2019Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0