TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC121614 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Atria One 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 7 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 1 South Glye Crescent Lane Edinburgh EH3 8EX | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 1 South Glye Crescent Lane Edinburgh EH3 8EX | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG à Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX le 14 mai 2018 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2016 | 19 pages | AA | ||||||||||
legacy | 80 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Notification de General Cable Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 juil. 2017 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Telewest Communications (Scotland Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 juil. 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
État du capital au 08 mai 2017
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge SC1216140014 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1216140008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1216140009 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1216140011 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1216140016 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1216140015 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Secrétaire | 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh Atria One | 151396090001 | |||||||
| DUNN, Robert Dominic | Administrateur | 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh Atria One | England | British | 179134020002 | |||||
| HIFZI, Mine Ozkan | Administrateur | 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh Atria One | England | British | 182167230001 | |||||
| BROADEST, Guy David | Secrétaire | Tile House Woodland Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | British | 96454660001 | ||||||
| BURNS, Clive | Secrétaire | The Cottage Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood AL4 8RX Wheathampstead Hertfordshire | British | 71073800001 | ||||||
| FLINT, David | Secrétaire | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | 35387900001 | ||||||
| HULL, Victoria Mary, Sol | Secrétaire | Flat 2 53 Palace Gardens Terrace Kensington W8 4SB London | British | 77283810001 | ||||||
| LAVER, John Michael | Secrétaire | Brook House Homestead Road TN8 6JD Edenbridge Kent | British | 8207040001 | ||||||
| MOORE, Brian | Secrétaire | 44 The Little Boltons SW10 9LL London | British | 33419000002 | ||||||
| SHEPHERD & WEDDERBURN | Secrétaire désigné | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh | 900030690001 | |||||||
| THORNTONS WS | Secrétaire désigné | 50 Castle Street DD1 3RU Dundee Tayside | 900003090001 | |||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| BAMBROUGH, Noel Raymond | Administrateur | 25 St. Edmund's Drive M4N 2P7 Toronto Ontario Canada | Canadian | 1171450002 | ||||||
| BRYAN, Danny Frank | Administrateur | The Marble Suite The Mansion Ottershaw Park KT16 0QG Ottershaw Surrey | American | 41071470001 | ||||||
| BRYSON, Gary Spath | Administrateur | 5132 South Hanover Street 80111 Englewood Colorado Usa | American | 36182070001 | ||||||
| BURDICK, Charles James | Administrateur | 9 Ormonde Place SW1W 8HX London | British-American | 52311710004 | ||||||
| CARLETON, Lawrence James | Administrateur | The Marble Suite The Mansion KT16 0QG Ottershaw Park Ottershaw Surrey | American | 36182000001 | ||||||
| COOK, Stephen Sands | Administrateur | 24a Redcliffe Square SW10 9JY London | British | 73000530008 | ||||||
| DAVIDSON, Stephen James | Administrateur | Hughenden Close Denner Hill HP16 0JJ Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 92784240001 | |||||
| DICKSON, Ian | Administrateur désigné | Enderley 19 Baldernock Road Milngavie G62 8DU Glasgow | Scotland | British | 900000230001 | |||||
| FLINT, David | Administrateur | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | British | 35387900001 | ||||||
| GALE, Robert Charles | Administrateur | 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | England | British | 96956740001 | |||||
| GRAHAM, David Robert | Administrateur | 65 Clabon Mews Cadogan Square SW1X 0EQ London | Canadian | 38492860002 | ||||||
| HAMACHEK, Ross Frank | Administrateur | 5011 Sedgwick Street 20016 Nw Washington Dc Usa 20016 | American | 4948230001 | ||||||
| HULL, Victoria Mary, Sol | Administrateur | Flat 2 53 Palace Gardens Terrace Kensington W8 4SB London | British | 77283810001 | ||||||
| ILLSLEY, Anthony Kim | Administrateur | 4 St Peters Road TW1 1QX Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 43836970001 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Administrateur | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MICHELS, Alan | Administrateur | Catalina Abbotswood Drive St Georges Hill KT13 0LT Weybridge Surrey | British | 43658810001 | ||||||
| MORSE, John Burke | Administrateur | 7906 Old Cedar Court Mclean Virginia 22102 Usa | American | 32758880001 | ||||||
| REXROTH, Lynn Charles | Administrateur | St Anton Woodlands Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | American | 49075080001 | ||||||
| SMITH, Neil Reynolds | Administrateur | Brettwood Green Lane Churt GU10 2PA Farnham Surrey | British | 79956240002 | ||||||
| STENHAM, Anthony William Paul | Administrateur | 4 The Grove Highgate N6 6JU London | British | 8281170001 | ||||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Administrateur | 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Administrateur | 1 South Gyle Crescent Lane Edinburgh EH12 9EG | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| VAN VALKENBURG, David Raynor | Administrateur | Flat 6 35/37 Grosvenor Square W1X 9AE London | American | 53941940001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Cable Limited | 04 juil. 2017 | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Telewest Communications (Scotland Holdings) Limited | 06 avr. 2016 | South Gyle Crescent Lane EH12 9EG Edinburgh 1 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 21 mars 2017 Livré le 23 mars 2017 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 01 févr. 2017 Livré le 07 févr. 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description N/A. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 26 avr. 2016 Livré le 27 avr. 2016 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 30 avr. 2015 Livré le 07 mai 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 30 mars 2015 Livré le 02 avr. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description N/A. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 28 janv. 2015 Livré le 06 févr. 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 04 avr. 2014 Livré le 10 avr. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 28 mars 2014 Livré le 02 avr. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 07 juin 2013 Livré le 18 juin 2013 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Confirmation deed | Créé le 03 mars 2011 Livré le 21 mars 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Pursuant to clause 12 of the group intercreditor agreement the new notes were hereby designated (see form MG01S). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite debenture | Créé le 10 juin 2010 Livré le 23 juin 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 26 sept. 1998 Livré le 13 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 24 juil. 1996 Livré le 09 août 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by the company and others | |
Brèves mentions Fixed and floating charges on various assets....... See ch microfiche for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 24 juil. 1996 Livré le 08 août 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by the company and others | |
Brèves mentions All property etc....... see ch microfiche for full details. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 13 juin 1994 Livré le 27 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by the company and others | |
Brèves mentions Fixed and floating charge see ch microfiche. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 13 juin 1994 Livré le 27 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
TELEWEST COMMUNICATIONS (CUMBERNAULD) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0