MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED

MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC125204
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Crutherland House And Spa
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MACDONALD HOTELS AND RESORTS LIMITED10 févr. 200410 févr. 2004
    MACDONALD HOTELS LIMITED04 déc. 200304 déc. 2003
    MACDONALD HOTELS PLC09 août 199009 août 1990
    AMBASSADOR HOTELS & LEISURE LIMITED02 juil. 199002 juil. 1990
    ORRMAC (NO:140) LIMITED24 mai 199024 mai 1990

    Quels sont les derniers comptes de MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le24 sept. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes24 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 sept. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mars 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 avr. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mars 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 26 sept. 2024

    20 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Gordon Fraser le 12 nov. 2021

    2 pagesCH01

    Période comptable précédente raccourcie du 25 sept. 2024 au 24 sept. 2024

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Gordon Fraser le 15 mai 2025

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Hugh Gillies le 15 mai 2025

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Iain Gillies le 15 mai 2025

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modifications à la charge flottante SC1252040026

    104 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1252040025

    104 pages466(Scot)

    Inscription de la charge SC1252040026, créée le 21 févr. 2025

    13 pagesMR01

    Notification de Macdonald Hotels Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 mai 2023

    2 pagesPSC02

    Cessation de Hsdl Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 mai 2023

    1 pagesPSC07

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Crutherland House and Spa Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ

    1 pagesAD04

    Comptes annuels établis au 28 sept. 2023

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1252040019 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1252040023 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1252040018 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1252040022 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FRASER, Robert Gordon
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Administrateur
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    ScotlandBritish289448940001
    GILLIES, Hugh
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Administrateur
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    United KingdomBritish301475200001
    GILLIES, Iain
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Administrateur
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    ScotlandBritish436470002
    BUSBY, James George William
    4 Murchison Road,Houston
    Bridge Of Weir
    PA6 7JU Renfrewshire
    Secrétaire
    4 Murchison Road,Houston
    Bridge Of Weir
    PA6 7JU Renfrewshire
    British584980003
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Secrétaire
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    GILLESPIE, Brendan
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    British65199400001
    PALMER, Alan Charles
    7 Earlsgate
    Brierie Hills
    PA6 7FB Houston
    Renfrewshire
    Secrétaire
    7 Earlsgate
    Brierie Hills
    PA6 7FB Houston
    Renfrewshire
    British89601520001
    ROSS, Mark
    58 Kettilstoun Mains
    EH49 6SL Linlithgow
    West Lothian
    Secrétaire
    58 Kettilstoun Mains
    EH49 6SL Linlithgow
    West Lothian
    British106803450001
    ORR MACQUEEN WS
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire désigné
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    900000160001
    BUSBY, James George William
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    Administrateur
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    United KingdomBritish584980007
    CARTER, Phil
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish291374460001
    CHRISTIE, Scott Sommervaille
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    Administrateur
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    ScotlandBritish104262520001
    CRAWFORD, Guy Lindsay Macintyre
    86 Kingston Hill
    KT2 7NP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    86 Kingston Hill
    KT2 7NP Kingston Upon Thames
    Surrey
    British77508520001
    DEMPSEY, Patrick Joseph Anthony
    Cuckoo Meadow Little Shardeloes
    HP7 0EF Old Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Cuckoo Meadow Little Shardeloes
    HP7 0EF Old Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish100598030001
    FALLS, Aaron Peter
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish279163090001
    FRASER, Robert Gordon
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish120322350003
    GILLIES, Iain
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish436470002
    GUILE, David Andrew
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish100133280001
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish65090920001
    KEARNEY, Douglas Richard
    11 Eastwoodmains Road
    G46 6QB Glasgow
    Administrateur
    11 Eastwoodmains Road
    G46 6QB Glasgow
    ScotlandBritish93762430001
    LERCHE, James Andrew
    Upper Westown Farmhouse Barras
    AB39 2XU Stonehaven
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Upper Westown Farmhouse Barras
    AB39 2XU Stonehaven
    Aberdeenshire
    British61618300001
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    Administrateur
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    ScotlandBritish43780001
    MACDONALD, Donald John
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish557590001
    MACDONALD, Donald John
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish557590001
    MACDONALD, Ruaridh
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish138199130001
    MACLEOD, Calum Alexander, Dr
    6 Westfield Terrace
    AB25 2RU Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    6 Westfield Terrace
    AB25 2RU Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish1085020001
    MCBURNIE, Jason
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    United KingdomBritish202600000001
    MCGEE, Jeremiah
    5 Knunck Knowles Drive
    BB7 2JF Clitheroe
    Lancashire
    Uk
    Administrateur
    5 Knunck Knowles Drive
    BB7 2JF Clitheroe
    Lancashire
    Uk
    Irish68330590001
    MURRAY, Rodger Grant
    24 Moston Terrace
    Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Moston Terrace
    Edinburgh
    British900000170001
    O'CALLAGHAN, Francis
    21 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    Administrateur
    21 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    ScotlandBritish557570001
    O'NEILL, Tara
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    IrelandIrish277153640001
    ORR, James Alexander Macconnell
    10 Learmonth Grove
    EH4 1BP Edinburgh
    Administrateur
    10 Learmonth Grove
    EH4 1BP Edinburgh
    ScotlandBritish81233650001
    PAJARES, Ramon
    38 Pont Street Mews
    SW1X 0AF London
    Administrateur
    38 Pont Street Mews
    SW1X 0AF London
    Spanish45733530002
    PAJARES, Ramon
    38 Pont Street Mews
    SW1X 0AF London
    Administrateur
    38 Pont Street Mews
    SW1X 0AF London
    Spanish45733530002
    SCOTT, John Hamilton
    7 Glengyle Terrace
    Edinburgh
    Administrateur désigné
    7 Glengyle Terrace
    Edinburgh
    British900000180001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACDONALD HOTELS INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Strathaven Road
    East Kilbride
    G75 0QJ Glasgow
    Crutherland House And Spa
    Scotland
    05 mai 2023
    Strathaven Road
    East Kilbride
    G75 0QJ Glasgow
    Crutherland House And Spa
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleScots Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc247423
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    HX1 2RG Halifax
    Trinity Road
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    HX1 2RG Halifax
    Trinity Road
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueCorporate
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02249630
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0