UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC125587 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Site G Tofthills Avenue Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022 | 16 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Adam Rhys Wynne Hughes en tant que directeur le 16 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bruno Claudio Oliveira Teixeira en tant que directeur le 23 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Innes Mackay en tant qu'administrateur le 19 août 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Frederic Castrec en tant qu'administrateur le 19 août 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Inscription de la charge SC1255870002, créée le 19 août 2022 | 20 pages | MR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Llp 6 Queens Road Aberdeen Scotland AB15 4ZT Scotland à Site G Tofthills Avenue Midmill Business Park Kintore Inverurie AB51 0QP le 01 sept. 2022 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Philip Nicholas Lanigan en tant que secrétaire le 19 août 2022 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Philip Nicholas Lanigan en tant qu'administrateur le 19 août 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven John Costello en tant que secrétaire le 19 août 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Statuts | 27 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 23 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Steven John Costello le 22 juil. 2022 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Caroline Allen en tant que directeur le 07 déc. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Joseph Mcshane en tant qu'administrateur le 07 déc. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Bruno Claudio Oliveira Teixeira en tant qu'administrateur le 07 déc. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANIGAN, Philip Nicholas | Secrétaire | Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Site G Tofthills Avenue Scotland | 299618740001 | |||||||
| CASTREC, Frederic | Administrateur | Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Site G Tofthills Avenue Scotland | France | French | 299627840001 | |||||
| LANIGAN, Philip Nicholas | Administrateur | Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Site G Tofthills Avenue Scotland | England | British | 42734310002 | |||||
| MACKAY, James Innes | Administrateur | Midmill Business Park Kintore AB51 0QP Inverurie Site G Tofthills Avenue Scotland | Scotland | British | 108844510001 | |||||
| MCSHANE, Paul Joseph | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | England | Irish | 218498550002 | |||||
| COSTELLO, Steven John | Secrétaire | Bath Road SL1 4DX Slough 270 Berkshire United Kingdom | 184502790001 | |||||||
| HAYHURST, Fred | Secrétaire | Sheffield Business Park Europa Link S9 1XH Sheffield Europa View South Yorkshire United Kingdom | 159575580001 | |||||||
| MACLEOD, George Paterson | Secrétaire | 145 Kings Gate AB2 6DL Aberdeen Aberdeenshire | British | 30567150001 | ||||||
| MACLEOD, Kenneth George | Secrétaire | 340 Queens Road AB15 8DT Aberdeen Aberdeenshire | British | 603660001 | ||||||
| MACLEOD, Patricia Margaret | Secrétaire | 145 Kings Gate AB2 6DL Aberdeen Aberdeenshire | British | 30567160001 | ||||||
| MIDDLETON, Sandra Elizabeth | Secrétaire désigné | Investment House 6 Union Row AB9 8DQ Aberdeen | British | 900000270001 | ||||||
| ROBINSON, Paul James | Secrétaire | 17 Moss Lane M33 6QD Sale Cheshire | British | 61464420001 | ||||||
| ALLEN, Caroline | Administrateur | Rosendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Farrington Road England England | United Kingdom | British | 241814400001 | |||||
| CAREY, Malcolm Timothy | Administrateur | 14111 Indian Wells Drive Houston Texas 77069 Usa | Usa | American | 135768760001 | |||||
| COGZELL, Matthew James | Administrateur | Moor Gate Portishead BS20 7FL Bristol 6 United Kingdom | England | British | 157755080001 | |||||
| COWLEY, John Mitchell | Administrateur | Hatch Place Lower Road SL6 9EJ Cookham 9 United Kingdom | England | British | 153045530001 | |||||
| DAVISON, Thomas Patrick | Administrateur | Sheffield Business Park Europa Link S9 1XE Sheffield Europa Court South Yorkshire United Kingdom | England | British | 178471340001 | |||||
| EVERETT, Alan | Administrateur | Anfield, Balnabruach, Portmahomack IV20 1YN Tain Ross-Shire | United Kingdom | British | 91840790001 | |||||
| LAAKE, Gregory Duane | Administrateur | 9410 Brentwood Lake Circle Spring Texas 77379 Usa | United States | United States | 104309910001 | |||||
| MACLEOD, George Paterson | Administrateur | 145 Kings Gate AB2 6DL Aberdeen Aberdeenshire | British | 30567150001 | ||||||
| MACLEOD, Kathleen | Administrateur | 340 Queens Road AB1 8DT Aberdeen Aberdeenshire | British | 1185750001 | ||||||
| MACLEOD, Kenneth George | Administrateur | 340 Queens Road AB15 8DT Aberdeen Aberdeenshire | British | 603660001 | ||||||
| MACLEOD, Patricia Margaret | Administrateur | 145 Kings Gate AB2 6DL Aberdeen Aberdeenshire | British | 30567160001 | ||||||
| MCNIVEN, Alan Ross | Administrateur désigné | Investment House 6 Union Row AB9 8DQ Aberdeen | British | 900000280001 | ||||||
| MOKLAK, Paul Daniel | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | United Kingdom | British | 217770510001 | |||||
| REED, JR, James Franklin | Administrateur | Pine Arbor 77066 Houston 5419 Texas United States | Usa | United States | 137281430001 | |||||
| RHODES, Fiona Elizabeth | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | United Kingdom | British | 200869110001 | |||||
| SMILEY, Mark Richard | Administrateur | Bath Road SL1 3YD Slough 210 Berkshire United Kingdom | England | British | 194271890001 | |||||
| SMITH, Michael Peter | Administrateur | Closes Hall Stump Cross Lane, Bolton By Bowland BB7 4LX Clitheroe Lancashire | British | 65426730001 | ||||||
| SOOD, Amit Kumar | Administrateur | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | England | British | 153181250001 | |||||
| STUBBS, Colin | Administrateur | 1 Porterfield Bank IV2 3HL Inverness Inverness Shire | British | 100665460001 | ||||||
| STUBBS, Susan | Administrateur | Europa Court Sheffield Business Park S9 1XE Sheffield 3 England | United Kingdom | British | 169624400001 | |||||
| TEIXEIRA, Bruno Claudio Oliveira | Administrateur | Farrington Road Rossendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England England | Portugal | Portuguese | 290495760001 | |||||
| WALKER, Alexander Davidson | Administrateur | Maa-Jaa Doocot Park AB45 1DW Banff | British | 497950002 | ||||||
| WYNNE HUGHES, Adam Rhys | Administrateur | Farrington Road BB11 5SW Burnley The Pipeline Centre England | England | British | 113722460001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pih Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Rosendale Road Industrial Estate BB11 5SW Burnley Farrington Road England England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
UNIVERSAL INSPECTION SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 19 août 2022 Livré le 06 sept. 2022 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 21 déc. 1992 Livré le 29 déc. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0