MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC141208 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Crutherland House And Spa Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 24 sept. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 24 juin 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 26 sept. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 avr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 31 mars 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 26 sept. 2024 | 19 pages | AA | ||
legacy | 42 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 42 pages | PARENT_ACC | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Gordon Fraser le 08 nov. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Période comptable précédente raccourcie du 25 sept. 2024 au 24 sept. 2024 | 1 pages | AA01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Gordon Fraser le 15 mai 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Hugh Gillies le 15 mai 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modifications à la charge flottante SC1412080021 | 104 pages | 466(Scot) | ||
Modifications à la charge flottante SC1412080023 | 104 pages | 466(Scot) | ||
Inscription de la charge SC1412080024, créée le 21 févr. 2025 | 55 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge SC1412080023, créée le 21 févr. 2025 | 13 pages | MR01 | ||
Notification de Macdonald Hotels Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 mai 2023 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Hsdl Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 mai 2023 | 1 pages | PSC07 | ||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Crutherland House and Spa Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ | 1 pages | AD04 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 28 sept. 2023 | 19 pages | AA | ||
legacy | 42 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 29 sept. 2022 | 22 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de Whiteside House Whiteside Industrial Estate Bathgate West Lothian EH48 2RX à Crutherland House and Spa Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ le 23 oct. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Satisfaction de la charge SC1412080017 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Qui sont les dirigeants de MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRASER, Robert Gordon | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | Scotland | British | 289448940001 | |||||
| GILLIES, Hugh | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | United Kingdom | British | 301475200001 | |||||
| SMITH, Gerard Henry | Administrateur | Strathaven Road G75 0QJ East Kilbride Crutherland House And Spa United Kingdom | United Kingdom | British | 289235270001 | |||||
| BUSBY, James George William | Secrétaire | 4 Murchison Road,Houston Bridge Of Weir PA6 7JU Renfrewshire | British | 584980003 | ||||||
| FRASER, Robert Gordon | Secrétaire | 1 Glebe Court KA1 3BD Kilmarnock Ayrshire | British | 120322350001 | ||||||
| GILLESPIE, Brendan | Secrétaire | 56 Blairbeth Road Rutherglen G73 4JQ Glasgow Lanarkshire | British | 65199400001 | ||||||
| PALMER, Alan Charles | Secrétaire | 7 Earlsgate Brierie Hills PA6 7FB Houston Renfrewshire | British | 89601520001 | ||||||
| ROSS, Mark | Secrétaire | 58 Kettilstoun Mains EH49 6SL Linlithgow West Lothian | British | 106803450001 | ||||||
| ORR MACQUEEN WS | Secrétaire désigné | 36 Heriot Row EH3 6ES Edinburgh | 900000160001 | |||||||
| BUSBY, James George William | Administrateur | 16 Fairyknowe Court Bothwell G71 8SZ Glasgow | United Kingdom | British | 584980007 | |||||
| CARTER, Phil | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 291374460001 | |||||
| CHRISTIE, Scott Sommervaille | Administrateur | Gospatric House Bankhead Road Dalmeny EH30 9TT Edinburgh | Scotland | British | 104262520001 | |||||
| COTTRELL, Jane | Administrateur | The Knapps Semington BA14 6JG Trowbridge 5 Wiltshire | United Kingdom | British | 130154220001 | |||||
| FALLS, Aaron Peter | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 279163090001 | |||||
| FRASER, Robert Gordon | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 120322350003 | |||||
| GILLIES, Iain | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 436470002 | |||||
| GORDON, James | Administrateur | 1f1 32 Deanpark Street EH4 1JN Edinburgh | British | 84334690001 | ||||||
| GUILE, David Andrew | Administrateur | Whiteside House Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate West Lothian | United Kingdom | British | 100133280001 | |||||
| GUILE, David Andrew | Administrateur | 5 Leaheath Way RG10 0TY Hurst Berkshire | United Kingdom | British | 100133280001 | |||||
| IRONS, Elizabeth Anne | Administrateur | 12b Leopold Place EH7 5LB Edinburgh | Scotland | British | 84334540001 | |||||
| LERCHE, James Andrew | Administrateur | Upper Westown Farmhouse Barras AB39 2XU Stonehaven Aberdeenshire | British | 61618300001 | ||||||
| MACDONALD, Angus Donald Mackintosh | Administrateur | 18 Hermitage Drive EH10 6BZ Edinburgh | Scotland | British | 43780001 | |||||
| MACDONALD, Donald John | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 557590001 | |||||
| MACDONALD, Ruaridh | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Scotland | British | 138199130001 | |||||
| MCBURNIE, Jason | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian Scotland | United Kingdom | British | 202600000001 | |||||
| MURRAY, Rodger Grant | Administrateur | 36 Heriot Row EH3 6ES Edinburgh Midlothian | British | 42591140001 | ||||||
| O'MALLEY, John Joseph | Administrateur | 5 Marsh Lane B91 2PG Sollihul West Midlands | British | 49893480001 | ||||||
| O'NEILL, Tara | Administrateur | Whiteside Industrial Estate EH48 2RX Bathgate Whiteside House West Lothian United Kingdom | Ireland | Irish | 277153640001 | |||||
| ORR, Pauline Anne | Administrateur | 9 Saxe Coburg Street EH3 5BN Edinburgh Midlothian | British | 52526750005 | ||||||
| PATERSON, Nicholas David Lyon | Administrateur | Ruthven House 7 Aviemore Gardens NN4 9XJ Northampton | British | 50835420002 | ||||||
| PAYNE, Beverly Dorothy Barbara | Administrateur | 7 Upland Road G14 9BG Glasgow Strathclyde | British | 84334390001 | ||||||
| POWELL, Garth | Administrateur | Tinkers Meadow Trematon PL12 4RS Saltash Cornwall | British | 84334600001 | ||||||
| SMITH, Gerard Henry | Administrateur | Dallarich Caledonian Crescent PH3 1NG Gleneagles Perthshire | United Kingdom | British | 40871240003 | |||||
| SMITH, Gerard Henry | Administrateur | Dallarich Caledonian Crescent PH3 1NG Gleneagles Perthshire | United Kingdom | British | 40871240003 | |||||
| WAITE, Iain David | Administrateur | 2 Broomfield Bowgreave PR3 1TG Preston | British | 84334440001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macdonald Hotels Investments Limited | 05 mai 2023 | Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ Glasgow Crutherland House And Spa Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Hsdl Nominees Limited | 06 avr. 2016 | HX1 2RG Halifax Trinity Road United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0