MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED

MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC141208
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Crutherland House And Spa
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAIRN MANAGEMENT LIMITED19 avr. 199319 avr. 1993
    MHL MANAGEMENT (NO.2) LIMITED12 nov. 199212 nov. 1992

    Quels sont les derniers comptes de MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le24 sept. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes24 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 sept. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mars 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 avr. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au31 mars 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 26 sept. 2024

    19 pagesAA

    legacy

    42 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    42 pagesPARENT_ACC

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Gordon Fraser le 08 nov. 2021

    2 pagesCH01

    Période comptable précédente raccourcie du 25 sept. 2024 au 24 sept. 2024

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Gordon Fraser le 15 mai 2025

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Hugh Gillies le 15 mai 2025

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modifications à la charge flottante SC1412080021

    104 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1412080023

    104 pages466(Scot)

    Inscription de la charge SC1412080024, créée le 21 févr. 2025

    55 pagesMR01

    Inscription de la charge SC1412080023, créée le 21 févr. 2025

    13 pagesMR01

    Notification de Macdonald Hotels Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 mai 2023

    2 pagesPSC02

    Cessation de Hsdl Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 mai 2023

    1 pagesPSC07

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Crutherland House and Spa Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ

    1 pagesAD04

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 28 sept. 2023

    19 pagesAA

    legacy

    42 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 29 sept. 2022

    22 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Whiteside House Whiteside Industrial Estate Bathgate West Lothian EH48 2RX à Crutherland House and Spa Strathaven Road East Kilbride G75 0QJ le 23 oct. 2023

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge SC1412080017 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FRASER, Robert Gordon
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Administrateur
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    ScotlandBritish289448940001
    GILLIES, Hugh
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Administrateur
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    United KingdomBritish301475200001
    SMITH, Gerard Henry
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    Administrateur
    Strathaven Road
    G75 0QJ East Kilbride
    Crutherland House And Spa
    United Kingdom
    United KingdomBritish289235270001
    BUSBY, James George William
    4 Murchison Road,Houston
    Bridge Of Weir
    PA6 7JU Renfrewshire
    Secrétaire
    4 Murchison Road,Houston
    Bridge Of Weir
    PA6 7JU Renfrewshire
    British584980003
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Secrétaire
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    GILLESPIE, Brendan
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    British65199400001
    PALMER, Alan Charles
    7 Earlsgate
    Brierie Hills
    PA6 7FB Houston
    Renfrewshire
    Secrétaire
    7 Earlsgate
    Brierie Hills
    PA6 7FB Houston
    Renfrewshire
    British89601520001
    ROSS, Mark
    58 Kettilstoun Mains
    EH49 6SL Linlithgow
    West Lothian
    Secrétaire
    58 Kettilstoun Mains
    EH49 6SL Linlithgow
    West Lothian
    British106803450001
    ORR MACQUEEN WS
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire désigné
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    900000160001
    BUSBY, James George William
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    Administrateur
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    United KingdomBritish584980007
    CARTER, Phil
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish291374460001
    CHRISTIE, Scott Sommervaille
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    Administrateur
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    ScotlandBritish104262520001
    COTTRELL, Jane
    The Knapps
    Semington
    BA14 6JG Trowbridge
    5
    Wiltshire
    Administrateur
    The Knapps
    Semington
    BA14 6JG Trowbridge
    5
    Wiltshire
    United KingdomBritish130154220001
    FALLS, Aaron Peter
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish279163090001
    FRASER, Robert Gordon
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish120322350003
    GILLIES, Iain
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish436470002
    GORDON, James
    1f1 32 Deanpark Street
    EH4 1JN Edinburgh
    Administrateur
    1f1 32 Deanpark Street
    EH4 1JN Edinburgh
    British84334690001
    GUILE, David Andrew
    Whiteside House
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    Whiteside House
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    West Lothian
    United KingdomBritish100133280001
    GUILE, David Andrew
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    Administrateur
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    United KingdomBritish100133280001
    IRONS, Elizabeth Anne
    12b Leopold Place
    EH7 5LB Edinburgh
    Administrateur
    12b Leopold Place
    EH7 5LB Edinburgh
    ScotlandBritish84334540001
    LERCHE, James Andrew
    Upper Westown Farmhouse Barras
    AB39 2XU Stonehaven
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Upper Westown Farmhouse Barras
    AB39 2XU Stonehaven
    Aberdeenshire
    British61618300001
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    Administrateur
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    ScotlandBritish43780001
    MACDONALD, Donald John
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish557590001
    MACDONALD, Ruaridh
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish138199130001
    MCBURNIE, Jason
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    Scotland
    United KingdomBritish202600000001
    MURRAY, Rodger Grant
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Midlothian
    British42591140001
    O'MALLEY, John Joseph
    5 Marsh Lane
    B91 2PG Sollihul
    West Midlands
    Administrateur
    5 Marsh Lane
    B91 2PG Sollihul
    West Midlands
    British49893480001
    O'NEILL, Tara
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Whiteside Industrial Estate
    EH48 2RX Bathgate
    Whiteside House
    West Lothian
    United Kingdom
    IrelandIrish277153640001
    ORR, Pauline Anne
    9 Saxe Coburg Street
    EH3 5BN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Saxe Coburg Street
    EH3 5BN Edinburgh
    Midlothian
    British52526750005
    PATERSON, Nicholas David Lyon
    Ruthven House 7 Aviemore Gardens
    NN4 9XJ Northampton
    Administrateur
    Ruthven House 7 Aviemore Gardens
    NN4 9XJ Northampton
    British50835420002
    PAYNE, Beverly Dorothy Barbara
    7 Upland Road
    G14 9BG Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    7 Upland Road
    G14 9BG Glasgow
    Strathclyde
    British84334390001
    POWELL, Garth
    Tinkers Meadow
    Trematon
    PL12 4RS Saltash
    Cornwall
    Administrateur
    Tinkers Meadow
    Trematon
    PL12 4RS Saltash
    Cornwall
    British84334600001
    SMITH, Gerard Henry
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    Administrateur
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    United KingdomBritish40871240003
    SMITH, Gerard Henry
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    Administrateur
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    United KingdomBritish40871240003
    WAITE, Iain David
    2 Broomfield
    Bowgreave
    PR3 1TG Preston
    Administrateur
    2 Broomfield
    Bowgreave
    PR3 1TG Preston
    British84334440001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACDONALD HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Strathaven Road
    East Kilbride
    G75 0QJ Glasgow
    Crutherland House And Spa
    Scotland
    05 mai 2023
    Strathaven Road
    East Kilbride
    G75 0QJ Glasgow
    Crutherland House And Spa
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleScots Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc125204
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    HX1 2RG Halifax
    Trinity Road
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    HX1 2RG Halifax
    Trinity Road
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueCorporate
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02249630
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0