LASER HOTELS THREE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLASER HOTELS THREE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC141209
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LASER HOTELS THREE LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe LASER HOTELS THREE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o HUDSON ADVISORS UK LIMITED
    First Floor, Quay 2
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LASER HOTELS THREE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MREF HOTELS THREE LIMITED07 févr. 200707 févr. 2007
    MACDONALD HOTELS (UK) LIMITED14 avr. 199814 avr. 1998
    MHL MANAGEMENT (NO.3) LIMITED12 nov. 199212 nov. 1992

    Quels sont les derniers comptes de LASER HOTELS THREE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour LASER HOTELS THREE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    7 pagesLIQ13(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 13 sept. 2019

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Vincent Frederic Marc Vernier en tant que directeur le 08 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Vincent Vernier en tant que secrétaire le 08 juil. 2019

    1 pagesTM02

    Satisfaction de la charge 40 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1412090041 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination de Mr Timothy Selwyn Jones en tant qu'administrateur le 13 déc. 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 12 nov. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Robert Edward Gray en tant que directeur le 24 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    19 pagesAA

    Satisfaction de la charge SC1412090042 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de John Brennan en tant que directeur le 04 mai 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Michael Gallagher en tant qu'administrateur le 20 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Darren William Guy en tant que directeur le 20 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Vincent Vernier le 13 nov. 2017

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 12 nov. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Neal Morar en tant que directeur le 03 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neal Morar en tant que secrétaire le 03 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Vincent Vernier en tant qu'administrateur le 06 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Vincent Vernier en tant que secrétaire le 06 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    18 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Edward Gray le 01 nov. 2016

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Neal Morar le 01 nov. 2016

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neal Morar le 01 nov. 2016

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de LASER HOTELS THREE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GALLAGHER, Michael
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    IrelandIrish243693110001
    JONES, Timothy Selwyn
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish226437520001
    BUSBY, James George William
    4 Murchison Road,Houston
    Bridge Of Weir
    PA6 7JU Renfrewshire
    Secrétaire
    4 Murchison Road,Houston
    Bridge Of Weir
    PA6 7JU Renfrewshire
    British584980003
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Secrétaire
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    GILLESPIE, Brendan
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    56 Blairbeth Road
    Rutherglen
    G73 4JQ Glasgow
    Lanarkshire
    British65199400001
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Secrétaire
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    197427780001
    PALMER, Alan Charles
    7 Earlsgate
    Brierie Hills
    PA6 7FB Houston
    Renfrewshire
    Secrétaire
    7 Earlsgate
    Brierie Hills
    PA6 7FB Houston
    Renfrewshire
    British89601520001
    SANDERSON, Timothy Robin Llewelyn
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Secrétaire
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    British69033180003
    VERNIER, Vincent
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2
    Secrétaire
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2
    239101540001
    ORR MACQUEEN W S
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    39211930001
    BRENNAN, John
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish211131960001
    BUSBY, James George William
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    Administrateur
    16 Fairyknowe Court
    Bothwell
    G71 8SZ Glasgow
    United KingdomBritish584980007
    CHRISTIE, Scott Sommervaille
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    Administrateur
    Gospatric House
    Bankhead Road Dalmeny
    EH30 9TT Edinburgh
    ScotlandBritish104262520001
    EDWARDS, Nicholas William John
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Administrateur
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    EnglandBritish166575000001
    FERGUSON DAVIE, Charles John
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Administrateur
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritish159387570001
    FIGGE, Heiko
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Administrateur
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritish183639640001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    United KingdomBritish120322350001
    GILBARD, Marc Edward Charles
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Administrateur
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritish29232300002
    GRAY, Robert Edward
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish188584900001
    GUILE, David Andrew
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    Administrateur
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    United KingdomBritish100133280001
    GUY, Darren
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish294582970001
    HALL, Steven
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Administrateur
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritish147752500001
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    Administrateur
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    ScotlandBritish43780001
    MACDONALD, Donald John
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish557590001
    MORAR, Neal
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish173110500001
    MURRAY, Rodger Grant
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Midlothian
    British42591140001
    O'MALLEY, John
    132 Widney Manor Road
    B91 3JJ Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    132 Widney Manor Road
    B91 3JJ Solihull
    West Midlands
    British84334340001
    ORR, Pauline Anne
    9 Saxe Coburg Street
    EH3 5BN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    9 Saxe Coburg Street
    EH3 5BN Edinburgh
    Midlothian
    British52526750005
    SIDWELL, Graham Robert
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Administrateur
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritish72844280004
    SMITH, Gerard Henry
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    Administrateur
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    United KingdomBritish40871240003
    SMITH, Gerard Henry
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    Administrateur
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    United KingdomBritish40871240003
    STANLEY, Graham Bryan
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    Administrateur
    15 Atholl Crescent
    Edinburgh
    EH3 8HA
    United KingdomBritish46112880007
    VERNIER, Vincent Frederic Marc
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2
    Administrateur
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    First Floor, Quay 2
    United KingdomFrench185884890003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LASER HOTELS THREE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    C/O Hudson Advisors Uk Limited
    United Kingdom
    24 mai 2016
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    C/O Hudson Advisors Uk Limited
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05893844
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    LASER HOTELS THREE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 févr. 2015
    Livré le 26 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch as Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 26 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 16 févr. 2015
    Livré le 24 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank
    Transactions
    • 24 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 août 2010
    Livré le 03 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 14 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 24 nov. 2005
    Livré le 07 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal charge over the freehold property known as bank house, lake road, bowness-on-windermere CU84188.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 31 oct. 2005
    Livré le 07 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Crutherland house hotel, strathaven road, east kilbride LAN42816.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 31 oct. 2005
    Livré le 07 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whiteside house, whiteside industrial estate, bathgate WLN9242.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 31 oct. 2005
    Livré le 07 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Inchyra lodge, grange road, polmont, falkirk STG33156.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 19 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 19 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 19 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All that freehold property known as botley park hotel, winchester road, boorley green, hants hp 370641 and hp 188618 see form 410 paper apart for further details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 19 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All that freehold property known as property known as kilhey court hotel, chorley road, standish, wigan gm 413206.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 22 oct. 2003
    Livré le 27 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under each of the relevant doucments
    Brèves mentions
    The freehold property known as the last drop hotel, haydock lane and 130, 132 and 134 hospital road, bromley cross, turton (title number GM235281).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 oct. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 sept. 2003
    Livré le 11 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whiteside house, whiteside industrial estate, bathgate--title number WLN9242.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 sept. 2003
    Livré le 11 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Inchyra lodge, grange road, polmont, falkirk--title number stg 33156.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 sept. 2003
    Livré le 11 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Crutherland house hotel, strathaven road, east kilbride--title number LAN42816.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 05 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Egerton house hotel, blackburn road, egerton--title number GM410176.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 05 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Dunkenhalgh hotel, blackburn road, clayton le moors, hinburn--title number LA721713.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 05 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The de monfort hotel, the square and abbey end, kenilworth--title number WK359414.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 05 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Albrighton hall and the principals house, albrighton near shrewsbury, shropshire--title numbers SL9972 and SL9023.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 05 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The bower hotel, hollingwood avenue, chadderton, greater manchester--title numbers GM826608 and GM826610.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 05 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The buckatree hall hotel and farm cottage, ercall lane, wellington, telford, shropshire--title numbers SL92817 and SL16554.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 05 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ansty hall hotel and land st shilton ansty, coventry, warwickshire--title numbers WK312327 and WK370731.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 05 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Botley park hotel and country club, winchester road, boorley green and the hawthorns, maddoxford lane, boorley green--title numbers HP370641 and HP188618.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 05 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The tickled trout hotel, preston new road, samlesbury, lancashire--title number LA721705.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 05 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Park house hotel, park street, shifnal, telford, shropshire--title number SL66539.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    LASER HOTELS THREE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 mai 2022Due to be dissolved on
    13 sept. 2019Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0