GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED

GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC147142
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7 Duncan Street
    EH9 1SZ Edinburgh
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CATLIN EPSILON LIMITED29 mai 200729 mai 2007
    WELLINGTON EPSILON LIMITED06 oct. 200406 oct. 2004
    PREMIUM EPSILON LIMITED22 oct. 199322 oct. 1993

    Quels sont les derniers comptes de GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jeremy Richard Holt Evans en tant que directeur le 31 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark John Tottman en tant qu'administrateur le 31 juil. 2023

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 15 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    16 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jeremy Richard Holt Evans le 02 mai 2018

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN à 7 Duncan Street Edinburgh EH9 1SZ le 08 mars 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 28 févr. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name23 févr. 2018

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de Catlin (Pul) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 déc. 2017

    1 pagesPSC07

    Notification de Nomina Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 déc. 2017

    2 pagesPSC02

    Nomination de Jeremy Richard Holt Evans en tant qu'administrateur le 14 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HAMPDEN LEGAL PLC
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    England
    Secrétaire
    Great Hampden
    HP16 9RD Great Missenden
    Hampden House
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement01988859
    56301100002
    TOTTMAN, Mark John
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritishUnderwriting Agent72513380002
    NOMINA PLC
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement03382553
    81968410003
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    British6386010002
    GLOVER, Michael Logan
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    Secrétaire
    Dunelm
    41. St. Catherines Road
    EN10 7LD Broxbourne
    Herts
    British94249710001
    GUYATT, Elizabeth Helen
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Secrétaire
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British100201680002
    NOONE, Lisa Marie
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    Secrétaire
    8 Paget Road
    IP1 3RP Ipswich
    Suffolk
    British72182310002
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Secrétaire
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    BritishDirector70960040001
    REES, Marie Louise
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Secrétaire
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    201004110001
    THOMAS, Heather Irene
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    Secrétaire
    5 Lambert Jones Mews
    Barbican
    EC2Y 8DP London
    British105936240001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secrétaire
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    WELLINGTON INSURANCE LIMITED
    88 Leadenhall Street
    EC3A 3BA London
    Secrétaire
    88 Leadenhall Street
    EC3A 3BA London
    100566440001
    AVERY, Julian Ralph
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    Administrateur
    Little Boarzell
    Hurst Green
    TN19 7QU Etchingham
    East Sussex
    United KingdomUkCompany Director37578750001
    BRADBROOK, Paul Richard
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritishInsurance Executive148983260001
    BURKE, Martin Thomas
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Albany, 26 Leafy Way
    Hutton
    CM13 2QW Brentwood
    Essex
    United KingdomIrishActuary240344510001
    BUSHER, Thomas George Story
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Manor Farm Cottage School Hill
    Soberton
    SO32 3PF Southampton
    Hampshire
    BritishCompany Director6386010002
    CALLAN, Robert
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritishAccountant130365420001
    CUSACK, Julian Michael
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    3 Eastern Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5BY Ipswich
    Suffolk
    BritishCompany Director84410430001
    EVANS, Jeremy Richard Holt
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    Administrateur
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    EnglandBritishCompany Director161542790001
    FRESHWATER, Neil Andrew
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritishAccountant125646370001
    HARDIE, David
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur désigné
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004620001
    HAYNES, Joseph Antony
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Administrateur
    40 Edwardes Square
    W8 6HH London
    BritishCompany Director9580170001
    HOOK, Christian Robert Macnachtan
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    BritishSolicitor45036950001
    IBESON, David Christopher Ben
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomBritishActuary52745170002
    IBESON, David Christopher Ben
    The Orchard House
    Beech Avenue, Effingham
    KT24 5PJ Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    The Orchard House
    Beech Avenue, Effingham
    KT24 5PJ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritishActuary52745170002
    IVORY, Ian Eric
    Ruthven House
    Ruthven
    PH12 8RF Blairgowrie
    Perthshire
    Administrateur
    Ruthven House
    Ruthven
    PH12 8RF Blairgowrie
    Perthshire
    United KingdomBritishInvestment Manager69668870001
    JARDINE, Paul Andrew
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    EnglandBritishActuary62337170003
    JENNER, Michael Eugene
    Moons Farm
    Barcombe Road
    TN22 3XG Piltdown
    East Sussex
    Administrateur
    Moons Farm
    Barcombe Road
    TN22 3XG Piltdown
    East Sussex
    BritishInsurance Broker12441700001
    LETSINGER, Katherine Lee
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    Administrateur
    55 Northumberland Place
    W2 5AS London
    EnglandBritish,AmericanCompany Director54716770009
    NOBLE, Timothy Peter, Sir
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    Administrateur
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    United KingdomBritishBusinessman685750001
    PEARCE, Philip
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    Administrateur
    4 Rabbits Farm Cottages
    Rabbits Road, South Darenth
    DA4 9JZ Dartford
    Kent
    BritishDirector70960040001
    PREBENSEN, Preben
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    Administrateur
    Dulverton
    TA22 9JH Somerset
    Hollam House
    United KingdomBritishCompany Director137567870001
    PRIMER, Daniel Francis
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    United KingdomAmericanLawyer112177980002
    SHAH, Nylesh
    22 Linkside
    Woodside Park
    N12 7LF London
    Administrateur
    22 Linkside
    Woodside Park
    N12 7LF London
    EnglandBritishActuary87504090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    14 déc. 2017
    40 Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    5th Floor
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03603617
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc147137
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    GRACECHURCH UTG NO. 359 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deposit trust deed
    Créé le 20 mai 2010
    Livré le 08 juin 2010
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All the future profits of the underwriting business of the company at lloyds subject to any prior charge contained in the premiums trust deed.
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's
    Transactions
    • 08 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Lloyd's security & trust deed
    Créé le 20 mai 2010
    Livré le 08 juin 2010
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    As security for the secured obligations referred to in paragraph 1 under “amounts secured all moneys or other property at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees (being the society and the other trustees for the time being of the trusts created by the trust deed) and all accumulations of income and the investments and other property for the time being representing the same. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's
    Transactions
    • 08 juin 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Amendment and restatement lloyd's american instrument 1995
    Créé le 24 mars 2009
    Livré le 14 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All losses, claims, returns of premiums, re-insurance premiums and other outgoings in connection with the 1992 and prior american business
    Brèves mentions
    All present and future assets including all premiums, reinsurance recoveries and other monies in connection with the members new american general business - see form 410 schedule for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 14 avr. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 mai 2009
    Lloyd's american trust deed
    Créé le 24 mars 2009
    Livré le 14 avr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All losses, claims, returns of premiums, re-insurance premiums and other outgoings in connection with the 1992 and prior american business
    Brèves mentions
    All premiums and other moneys payable during the trust term to or for the account - see form 410 schedule for full details.
    Personnes ayant droit
    • The American Trustee
    Transactions
    • 14 avr. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 mai 2009
    Deposit trust deed (third party deposit)
    Créé le 15 juin 2007
    Livré le 20 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All the obligations and sums payable
    Brèves mentions
    All moneys or other property, all future profits of the underwriting business and the moneys or other property approved - see form 410 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's
    Transactions
    • 20 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Security and trust deed (letter of credit and bank guarantee)
    Créé le 02 févr. 2007
    Livré le 22 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All moneys or other property at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees. All future underwriting profits. See form 410 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 22 févr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Security and trust deed (letter of credit and bank guarantee)
    Créé le 01 janv. 2006
    Livré le 06 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All moneys or other property at any time paid or transferred to or under the direct or indirect control of the trustees for the time being.
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Trust deed
    Créé le 01 janv. 2004
    Livré le 20 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The property constituting the trust principal but excluding the investment income from time to time earned thereon-see form 410 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyd's and Another as Trustee
    Transactions
    • 20 janv. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Security and trust deed
    Créé le 30 oct. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All moneys or other property and all future profits of the underwriting business. See original mortgage document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds asia (offshire policies) instrument 2002 (general business of all underwriting members)
    Créé le 13 févr. 2002
    Livré le 25 févr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    The losses, claims, returns of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other permitted offshore policies trust outgoings
    Brèves mentions
    All the present and future assets of the member comprised in the members offshire policies trust fund constituted under and pursuant to the offshore policies instrument, full particulars of which assets are set out in clause 3 of s chedule 2 to the offshore policies instrument--see mort doc for full listing.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 25 févr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds asia (singapore policies) instrument 2002 (general business of all underwriting members)
    Créé le 13 févr. 2002
    Livré le 25 févr. 2002
    En cours
    Montant garanti
    The losses, claims, rerturn of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other permitted singaport policies trust outgoings
    Brèves mentions
    All the present and future assets of the member comprised in the members singapore policies trust fund constituted under and pursuant to the singapore policies instrument, full particulars of which assets are set out in clause 3 of schedule 2 to the singapore policies instrument--see mort doc for full listing.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 25 févr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds united states situs credit for reinsurance trust deed
    Créé le 03 janv. 2002
    Livré le 22 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    The payment of all expenditure and fees of the trustee
    Brèves mentions
    The principal at any time but excluding the investment income from time to time earned thereon.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 22 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds canadian trust deed
    Créé le 25 mai 2001
    Livré le 13 juin 2001
    En cours
    Montant garanti
    The losses, claims, returns of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other permitted canadian trust outgoings
    Brèves mentions
    All the present and future assets of the member comprised in the members canadian trust fund constituted under and pursuant to the lloyds canadian trust deed full particulars of which assets are set out in clause 3 of and schedule 2 to the lloyds canadian trust deed, including the following (I) all premiums, reinsurance recoveries, rights of salvage and subrogation and other monies whatsoever in connection with the members canadian business and all other interest of the member therin (ii) all canadian rights of recovery.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Corporation of Canada
    Transactions
    • 13 juin 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds canadian margin fund trust deed
    Créé le 25 mai 2001
    Livré le 13 juin 2001
    En cours
    Montant garanti
    Trustee priority claims
    Brèves mentions
    All interest of the company in present and future assets comprised in the margin fund constituted under the trust deed including the following a) the contributions paid to the margin fund by or on behalf of the company pursuant to the lloyds canadian business requirements 2001 made by the council of lloyds or any other requirements of the council of lloyds. B)all monies, investments, income, gains or other asets at any time representing or accruing to the contributions referred to above.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Corporation of Canada
    Transactions
    • 13 juin 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds illinois licensed and 1104 multiple trust deed
    Créé le 30 mars 2001
    Livré le 18 avr. 2001
    En cours
    Montant garanti
    Any sum of money which is or becomes payable to a policyholder to pay a claim arising under an illinois policy
    Brèves mentions
    õAll present and future assets comprised in the corporated members trust fund constituted under and pursuant to the trust deed, including all monies (including future accretions to the trust fund), investments, income, gains and other assets representing oraccruing to that trust fund.
    Personnes ayant droit
    • Mellon Trust Company
    Transactions
    • 18 avr. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Amendment and restatement lloyd's american instrument 1995
    Créé le 28 déc. 2000
    Livré le 17 janv. 2001
    En cours
    Montant garanti
    The losses, claims, returns of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other "permitted dollar trust outgoings"
    Brèves mentions
    All the present and future assets of the member comprised in the m embersdollar trust fund constituted under and pursuant to the 1995 american instrumen (corporate member) full particulars of which assets are set out in clause 3 ofand schedule 2 to the 1995 american instrument (corporate members)-see mortgagedocument for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Society Incorporated by Lloyds Act 1871 by the Name of Lloyd's
    Transactions
    • 17 janv. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds canadian trust deed
    Créé le 28 déc. 2000
    Livré le 17 janv. 2001
    En cours
    Montant garanti
    The losses, claims, return of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other "permitted canadian trust outgoings"
    Brèves mentions
    All the present and future assets of the member comprised in the m embers canadian trust fund constituted under and pursuant to the lloyds canadian trust deed full particulars of which assets are set out in clause 3 of and schedule 2 to the lloyds canadian trust deed- see mortgage document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Trust Corporation of Canada
    Transactions
    • 17 janv. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds australian joint asset trust deed (no.1)
    Créé le 06 juin 2000
    Livré le 22 juin 2000
    En cours
    Montant garanti
    All claims of or submitted by a holder of any australian policy to which the trust deed applies
    Brèves mentions
    All the present and future assets comprised in the trust fund constituted under and pursuant to the trust deed including all monies, investments, income, gains and other assets representing or accruing to the trust fund.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 22 juin 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds australian joint asset trust deed (no.2)
    Créé le 06 juin 2000
    Livré le 22 juin 2000
    En cours
    Montant garanti
    All claims of or submitted by a holder of any australian policy to which the trust deed applies
    Brèves mentions
    All the present and future assets comprised in the trust fund constituted under and pursuant to the trust deed including all monies, investments, income, gains and other assets representing or accruing to the trust fund.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 22 juin 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds australian trust deed
    Créé le 06 juin 2000
    Livré le 22 juin 2000
    En cours
    Montant garanti
    All claims of or submitted by a holder of any australian policy to which the trust deed applies
    Brèves mentions
    The share of the corporate member in all present and future assets comprised in the trust fund constituted under and pursuant to the trust deed including all monies, investments, income, gains and other assets representing or accruing to that share.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 22 juin 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Lloyds premiums trust deed
    Créé le 01 janv. 1999
    Livré le 21 janv. 1999
    En cours
    Montant garanti
    The losses, claims, returns of premiums, reinsurance premiums, expenses, obligations and other "permitted trust outgoings"
    Brèves mentions
    All thepresent and future assets of the corporate members comprised in the trust fund constituted under and pursuant to the trust deed full particulars which assets are set out in clause 2 and schedule 2 to the trust deed.
    Personnes ayant droit
    • The Society Incorporated by Lloyds Act 1871 by the Name of Lloyds
    Transactions
    • 21 janv. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 12 août 1998
    Livré le 01 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 13 août 1997
    Livré le 22 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A revolving loan facility of £100,000,000 or its equivalent from time to time in U.S. dollars
    Brèves mentions
    All right,title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 22 août 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 13 août 1997
    Livré le 22 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A revolving loan facility of £100,000,000 or its equivalent from time to time in U.S. dollars
    Brèves mentions
    All right,title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 22 août 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 13 août 1997
    Livré le 22 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A revolving loan facility of £100,000,000 or its equivalent from time to time in U.S. dollars
    Brèves mentions
    All right,title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 22 août 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0