STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED

STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC153127
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED ?

    • (4521) /

    Où se situe STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DUNWILCO (416) LIMITED16 sept. 199416 sept. 1994

    Quels sont les derniers comptes de STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approve sale entire share capital of subsidiary 07/09/2011
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approve sale entire share cap of subsidiary 06/09/2011
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    11 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    4 pagesMG05s

    legacy

    4 pagesMG05s

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 août 2011

    État du capital au 03 août 2011

    • Capital: GBP 500
    SH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share purchase agreement approved 28/01/2011
    RES13

    legacy

    3 pagesMG02s

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ le 02 févr. 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808750001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    LEES, Gordon
    8 Grange Gardens
    Monifieth
    DD5 4NA Tayside
    Secrétaire
    8 Grange Gardens
    Monifieth
    DD5 4NA Tayside
    British82127910001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secrétaire
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secrétaire
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secrétaire
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    BETHUNE, Hamish William
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    Administrateur
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    British1198020003
    COOPER, James Arthur
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    British43500170001
    COUTTS, Maureen Sheila
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur désigné
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004630001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FRASER, Gordon Mackenzie
    Cortachy Cottage
    Auchterhouse
    Dundee
    Administrateur
    Cortachy Cottage
    Auchterhouse
    Dundee
    British16138750005
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    HARDIE, David
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur désigné
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004620001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Administrateur
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    OGILVIE, Stuart
    46 Holly Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LZ Dundee
    Administrateur
    46 Holly Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LZ Dundee
    British39560000001
    WHITAKER, David Alexander
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    Administrateur
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    ScotlandBritish26878690001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001

    STRATHMARTINE (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 16 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 sept. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • 03 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Shares pledge
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 15 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due all sums due or to become due
    Brèves mentions
    900 ordinary shares in castlegait homes limited.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Shares pledge
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 15 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    12,100 ordinary shares over glademartin homes limited.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 15 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 sept. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)
    • 03 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 26 sept. 2001
    Livré le 04 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 oct. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 03 févr. 1995
    Livré le 14 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 févr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0