AZK99 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAZK99 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC162889
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AZK99 LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe AZK99 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    26 Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AZK99 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MURRAY METALS GROUP LIMITED10 mai 200110 mai 2001
    MURRAY METAL HOLDINGS LIMITED18 sept. 199718 sept. 1997
    MURRAY MSL LIMITED27 sept. 199627 sept. 1996
    MIMTEC SERVICES (1996) LIMITED19 janv. 199619 janv. 1996

    Quels sont les derniers comptes de AZK99 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AZK99 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour AZK99 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed murray metals group LIMITED\certificate issued on 24/06/15
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name24 juin 2015

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2014 au 31 déc. 2014

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 févr. 2015

    État du capital au 27 févr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 10 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DR à 26 Charlotte Square Edinburgh EH2 4ET le 27 févr. 2015

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de David William Murray Horne en tant que secrétaire le 17 nov. 2014

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Michael Scott Mcgill en tant que directeur le 17 nov. 2014

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 28 août 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 janv. 2014

    État du capital au 14 janv. 2014

    • Capital: GBP 8,057,935
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2012

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sir David Edward Murray le 17 mai 2012

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    16 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 07 mars 2012

    • Capital: GBP 8,057,935
    4 pagesSH01

    Qui sont les dirigeants de AZK99 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MURRAY, David Edward
    Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    26
    Scotland
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4ET Edinburgh
    26
    Scotland
    ScotlandBritish34535230003
    HEGARTY, Eamon James
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Secrétaire
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    British36657620002
    HORNE, David William Murray
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Secrétaire
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    British41593900004
    HORNE, David William Murray
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    British41593900002
    TAHIR, Sarah
    13 Marchmont Street
    EH9 1EL Edinburgh
    Secrétaire
    13 Marchmont Street
    EH9 1EL Edinburgh
    British38346270001
    COCKBURN, Kenneth Andrew
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    Administrateur
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    ScotlandBritish835820002
    COCKBURN, Kenneth Andrew
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    Administrateur
    6 East Comiston
    EH10 6RZ Edinburgh
    ScotlandBritish835820002
    HEGARTY, Eamon James
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Administrateur
    1 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    ScotlandBritish36657620002
    HILL, Graeme Everitt
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    EnglandBritish144984260001
    HORNE, David William Murray
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    64 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    British41593900002
    MACDONALD, James
    175 Whitehouse Road
    Barnton
    EH4 6DD Edinburgh
    Administrateur
    175 Whitehouse Road
    Barnton
    EH4 6DD Edinburgh
    ScotlandBritish159510002
    MCGILL, Michael Scott
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    ScotlandBritish99070570001
    MCKIE, Robert Gordon
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    4 Blinkbonny Crescent
    EH4 3NB Edinburgh
    Midlothian
    British30277090001
    WILSON, James Donald Gilmour
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    Administrateur
    Charlotte Square
    EH2 4DR Edinburgh
    10
    ScotlandBritish69298770001

    AZK99 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Shares pledge
    Créé le 29 juin 2010
    Livré le 09 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The pledgors entire right, title and interest in and to the shares.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 20 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Shares pledge
    Créé le 21 avr. 2010
    Livré le 06 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The pledgor's entire, right, title and interest in and to the shares.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 20 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation in security of accounts
    Créé le 20 avr. 2010
    Livré le 06 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Entire, right, title and interest in and to the accounts and the deposits.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 20 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 20 avr. 2010
    Livré le 04 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 20 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 févr. 1996
    Livré le 04 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mars 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0