PORTMAN HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPORTMAN HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC167279
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PORTMAN HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PORTMAN HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1st Floor 1 Waterloo Street
    G2 6AY Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PORTMAN HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MACROCOM (365) LIMITED26 juil. 199626 juil. 1996

    Quels sont les derniers comptes de PORTMAN HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour PORTMAN HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Mawasem Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 août 2020

    2 pagesPSC05

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2019 au 31 déc. 2019

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Level 2, Plaza Tower the Plaza East Kilbride Glasgow G74 1LW Scotland à 1st Floor 1 Waterloo Street Glasgow G2 6AY le 06 mars 2020

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2018

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Suite 4, Level 8, Plaza Tower the Plaza East Kilbride Glasgow G74 1LW Scotland à Level 2, Plaza Tower the Plaza East Kilbride Glasgow G74 1LW le 29 mai 2019

    1 pagesAD01

    État du capital au 05 mars 2019

    • Capital: GBP 51.03
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 26 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 4th Floor 62 Hamilton Road Motherwell ML1 3DA Scotland à Suite 4, Level 8, Plaza Tower the Plaza East Kilbride Glasgow G74 1LW le 08 août 2018

    1 pagesAD01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2017 au 30 juin 2018

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de John Dick en tant que directeur le 31 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Alexander Canavan en tant que directeur le 31 août 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Christopher Nevin en tant que secrétaire le 01 sept. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Alexander Canavan en tant que secrétaire le 31 août 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Adrian Clive Parkes en tant que directeur le 31 août 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 24 déc. 2016

    20 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PORTMAN HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NEVIN, Mark Christopher
    1 Waterloo Street
    G2 6AY Glasgow
    1st Floor
    Scotland
    Secrétaire
    1 Waterloo Street
    G2 6AY Glasgow
    1st Floor
    Scotland
    238199000001
    NEVIN, Mark Christopher
    1 Waterloo Street
    G2 6AY Glasgow
    1st Floor
    Scotland
    Administrateur
    1 Waterloo Street
    G2 6AY Glasgow
    1st Floor
    Scotland
    EnglandBritish214012140001
    WALSH, Redmond Gavin Mcginty
    1 Waterloo Street
    G2 6AY Glasgow
    1st Floor
    Scotland
    Administrateur
    1 Waterloo Street
    G2 6AY Glasgow
    1st Floor
    Scotland
    Northern IrelandBritish209878750001
    CANAVAN, David Alexander
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    Secrétaire
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    British55503310001
    FLACK, Graham Norman
    81 Beaulieu Close
    SL3 9DD Datchett
    Berks
    Secrétaire
    81 Beaulieu Close
    SL3 9DD Datchett
    Berks
    British38072430001
    FLINT, David
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Secrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British900000220001
    MACROBERTS
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Secrétaire
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    32443220001
    ALDRIDGE, Mark Ewart
    Dickson Minto W.S.
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Administrateur
    Dickson Minto W.S.
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    EnglandBritish66832950001
    ALLEN, Stephen David
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Hbj Gateley
    Scotland
    Administrateur
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Hbj Gateley
    Scotland
    EnglandBritish96472030001
    ANDERSON, Douglas Mcqueen
    7 Baillie Drive
    Bearsden
    Glasgow
    Administrateur
    7 Baillie Drive
    Bearsden
    Glasgow
    British647630001
    CANAVAN, David Alexander
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    Administrateur
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish55503310001
    DICK, John
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    Administrateur
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    ScotlandBritish195263440001
    DICKSON, Ian
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Administrateur désigné
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    ScotlandBritish900000230001
    FLACK, Graham Norman
    Atworth
    16 Cawdell Drive
    LE12 5BW Long Whatton
    Leicestershire
    Administrateur
    Atworth
    16 Cawdell Drive
    LE12 5BW Long Whatton
    Leicestershire
    British38072430004
    FLINT, David
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Administrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British900000220001
    GOVAN, Robert Duncan
    The Granary
    FK6 5HH Myothill
    Stirlingshire
    Administrateur
    The Granary
    FK6 5HH Myothill
    Stirlingshire
    United KingdomBritish122100630002
    HARE, Michael John
    Dickson Minto W.S.
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Administrateur
    Dickson Minto W.S.
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    United KingdomBritish19204450005
    JONES, Peter Geoffrey
    9 Copperfields
    HP9 2NS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    9 Copperfields
    HP9 2NS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish86919060001
    LYNCH, John Francis
    136 Alnwickhill Road
    EH16 6NQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    136 Alnwickhill Road
    EH16 6NQ Edinburgh
    Midlothian
    British12193430001
    MCCANN, Anthony Joseph
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    Administrateur
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    British20509810002
    MCINTOSH, Ruth Joanne
    32 Duke Road
    W4 2DD London
    Administrateur
    32 Duke Road
    W4 2DD London
    British62831460002
    MURPHY, Dawn Patricia
    Dickson Minto W.S.
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Administrateur
    Dickson Minto W.S.
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    EnglandBritish93161300001
    PARKES, Adrian Clive
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    Administrateur
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    EnglandBritish153563230001
    SMAILL, Peter Menzies
    Currie Mains House
    EH23 4RA Borthwick
    Midlothian
    Administrateur
    Currie Mains House
    EH23 4RA Borthwick
    Midlothian
    United KingdomBritish51552830001
    WORMSLEY, Alister Gerard
    Hunters Moon Long Mill Lane
    TN15 8QD Crouch
    Kent
    Administrateur
    Hunters Moon Long Mill Lane
    TN15 8QD Crouch
    Kent
    United KingdomBritish114205820001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PORTMAN HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Clarity Travel Ltd
    56 Oxford Street
    M1 6EU Manchester
    4th Floor Broadhurst House
    England
    06 avr. 2016
    56 Oxford Street
    M1 6EU Manchester
    4th Floor Broadhurst House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement07413801
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    PORTMAN HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 20 févr. 2008
    Livré le 05 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 mars 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0