MACROCOM (371) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACROCOM (371) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC168100
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACROCOM (371) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe MACROCOM (371) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4th Floor 62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MACROCOM (371) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour MACROCOM (371) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2017 au 30 juin 2018

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Redmond Gavin Mcginty Walsh en tant qu'administrateur le 01 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Alexander Canavan en tant que directeur le 31 août 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Mark Christopher Nevin en tant que secrétaire le 01 sept. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Alexander Canavan en tant que secrétaire le 31 août 2017

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 05 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Portman Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov. 2016

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Adrian Clive Parkes en tant que directeur le 31 août 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Hbj Gateley Exchange Tower 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EH Scotland à 4th Floor 62 Hamilton Road Motherwell ML1 3DA le 22 mai 2017

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Mark Christopher Nevin en tant qu'administrateur le 01 avr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen David Allen en tant que directeur le 31 mars 2017

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Dickson Minto Ws 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF à Hbj Gateley Exchange Tower 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EH le 28 nov. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 05 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Michael John Hare en tant que directeur le 21 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 sept. 2015

    État du capital au 30 sept. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Dawn Murphy en tant que directeur le 28 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen David Allen en tant qu'administrateur le 27 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 sept. 2014

    État du capital au 10 sept. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2013

    État du capital au 09 sept. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Qui sont les dirigeants de MACROCOM (371) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NEVIN, Mark Christopher
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    Secrétaire
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    238590630001
    NEVIN, Mark Christopher
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    Administrateur
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    EnglandBritish214012140001
    WALSH, Redmond Gavin Mcginty
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    Administrateur
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    IrelandBritish238589500001
    CANAVAN, David Alexander
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    Secrétaire
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    British152167080001
    FLACK, Graham Norman
    Atworth
    16 Cawdell Drive
    LE12 5BW Long Whatton
    Leicestershire
    Secrétaire
    Atworth
    16 Cawdell Drive
    LE12 5BW Long Whatton
    Leicestershire
    British38072430004
    FLINT, David
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Secrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British900000220001
    ALLEN, Stephen David
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Hbj Gateley
    Scotland
    Administrateur
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Hbj Gateley
    Scotland
    EnglandBritish96472030001
    ANDERSON, Douglas Mcqueen
    7 Baillie Drive
    Bearsden
    Glasgow
    Administrateur
    7 Baillie Drive
    Bearsden
    Glasgow
    British647630001
    CANAVAN, David Alexander
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    Administrateur
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish55503310001
    DICKSON, Ian
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Administrateur désigné
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    ScotlandBritish900000230001
    FLACK, Graham Norman
    Atworth
    16 Cawdell Drive
    LE12 5BW Long Whatton
    Leicestershire
    Administrateur
    Atworth
    16 Cawdell Drive
    LE12 5BW Long Whatton
    Leicestershire
    British38072430004
    FLINT, David
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Administrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British900000220001
    GOVAN, Robert Duncan
    The Granary
    FK6 5HH Myothill
    Stirlingshire
    Administrateur
    The Granary
    FK6 5HH Myothill
    Stirlingshire
    United KingdomBritish122100630002
    HARE, Michael John
    Dickson Minto Ws
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Administrateur
    Dickson Minto Ws
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    United KingdomBritish19204450005
    LYNCH, John Francis
    136 Alnwickhill Road
    EH16 6NQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    136 Alnwickhill Road
    EH16 6NQ Edinburgh
    Midlothian
    British12193430001
    MURPHY, Dawn Patricia
    Dickson Minto Ws
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Administrateur
    Dickson Minto Ws
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    EnglandBritish93161300001
    PARKES, Adrian Clive
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    Administrateur
    62 Hamilton Road
    ML1 3DA Motherwell
    4th Floor
    Scotland
    EnglandBritish163316880001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACROCOM (371) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mawasem Limited
    Dyson Way
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0WN Stafford
    5
    England
    06 avr. 2016
    Dyson Way
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0WN Stafford
    5
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement07413801
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0