GLADEMARTIN HOMES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GLADEMARTIN HOMES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC183217 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GLADEMARTIN HOMES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Regency House Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GLADEMARTIN HOMES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour GLADEMARTIN HOMES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG03s | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02s | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 4 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 23 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ le 02 févr. 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Dominic Joseph Lavelle en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robin Johnson en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Joanne Elizabeth Massey en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Robin Simon Johnson le 24 nov. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 13 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination d'un directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Dominic Joseph Lavelle en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 14 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 33 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 14 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GLADEMARTIN HOMES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secrétaire | Ridgeway Road RH1 6PQ Redhill 35 Surrey United Kingdom | 147809090001 | |||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050002 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| GANDHI, Devendra | Secrétaire | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secrétaire | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MASON, Eddie Roy | Secrétaire | 14 John Huband Drive Birkhill DD2 5RY Dundee | British | 606150007 | ||||||
| MOTION, Michelle Hunter | Secrétaire | 11 Curlew Brae EH54 6UG Livingston | British | 78545300002 | ||||||
| URQUHART, Roderick Macduff | Secrétaire | The Hall Samuelston EH41 4HG Haddington E Lothian | British | 562500001 | ||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secrétaire désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| BEAZER, Anthony Hadyn | Administrateur | 172b West Hill Putney SW15 3SL London | United Kingdom | British | 91412650001 | |||||
| BETHUNE, Hamish William | Administrateur | Auchenross PH6 2JU Comrie Perthshire | British | 1198020003 | ||||||
| COOPER, James Arthur | Administrateur | 4 Maclean Grove East Kilbride G74 4TJ Glasgow Lanarkshire | British | 43500170001 | ||||||
| DIPRE, John Vivian | Administrateur | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Administrateur | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| GAFFNEY, David | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Administrateur | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| JONES, Steve Keith | Administrateur | 3 Frances Green Beaulieu Park CM1 6EG Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 171220150001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Administrateur | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MCGUINNESS, Neil Stephen | Administrateur | Hazeldean Avenue EH51 0NS Boness 32 West Lothian | United Kingdom | British | 83466350002 | |||||
| WOTHERSPOON, Robert John | Administrateur | Glenlyon House Fortingall PH15 2LN Aberfeldy Perthshire | Scotland | British | 161858620001 | |||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Administrateur désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
GLADEMARTIN HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 30 déc. 2008 Livré le 14 janv. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 30 déc. 2008 Livré le 08 janv. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 26 sept. 2001 Livré le 08 oct. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 19 juil. 2000 Livré le 25 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Site at south william street/victoria street, perth. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 01 déc. 1999 Livré le 06 déc. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0