GLADEMARTIN HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGLADEMARTIN HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC183217
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GLADEMARTIN HOMES LIMITED ?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Où se situe GLADEMARTIN HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GLADEMARTIN HOMES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KILMARTIN HOMES (ARBROATH) LTD. 20 déc. 199920 déc. 1999
    KILMARTIN HOMES LIMITED26 juil. 199926 juil. 1999
    FIFE FOOTBALL ZONE LIMITED06 mai 199806 mai 1998
    CARETRUE MANAGEMENT LIMITED23 févr. 199823 févr. 1998

    Quels sont les derniers comptes de GLADEMARTIN HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour GLADEMARTIN HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 févr. 2010

    État du capital au 25 févr. 2010

    • Capital: GBP 12,100
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ le 02 févr. 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dominic Joseph Lavelle en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robin Johnson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Joanne Elizabeth Massey en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Modification des coordonnées du secrétaire Robin Simon Johnson le 24 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 13 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Dominic Joseph Lavelle en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    14 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    33 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GLADEMARTIN HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147809090001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secrétaire
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Secrétaire
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    British78545300002
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secrétaire
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Administrateur
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritish91412650001
    BETHUNE, Hamish William
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    Administrateur
    Auchenross
    PH6 2JU Comrie
    Perthshire
    British1198020003
    COOPER, James Arthur
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    4 Maclean Grove
    East Kilbride
    G74 4TJ Glasgow
    Lanarkshire
    British43500170001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    JONES, Steve Keith
    3 Frances Green
    Beaulieu Park
    CM1 6EG Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    3 Frances Green
    Beaulieu Park
    CM1 6EG Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish171220150001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Administrateur
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    GLADEMARTIN HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 26 sept. 2001
    Livré le 08 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 oct. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 19 juil. 2000
    Livré le 25 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Site at south william street/victoria street, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 juil. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 01 déc. 1999
    Livré le 06 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 déc. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0