WATERFRONT EDINBURGH LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | WATERFRONT EDINBURGH LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Liquidation |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC200223 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?
| Adresse du siège social | Titanium 1 King's Inch Place PA4 8WF Renfrew |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2022 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2023 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 sept. 2023 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 11 oct. 2023 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 sept. 2022 |
| En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination de Councillor Lezley Marion Cameron en tant qu'administrateur le 06 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jane Meagher en tant que directeur le 24 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Councillor Danny Aston en tant qu'administrateur le 27 juin 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Waverley Court 4 East Market Street Edinburgh EH8 8BG Scotland à Titanium 1 King's Inch Place Renfrew PA4 8WF le 07 déc. 2022 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2021 | 22 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Councillor Jane Meagher en tant qu'administrateur le 30 juin 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lezley Marion Cameron en tant que directeur le 30 juin 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Katherine Rosa Campbell en tant que directeur le 30 juin 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020 | 22 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Lezley Marion Cameron le 16 sept. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019 | 25 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2019 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2018 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de The Edi Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 juin 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Eric Weir Adair en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017 | 25 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Hugh Alexander Rutherford en tant que directeur le 30 mai 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3 Cockburn Street Edinburgh EH1 1QB Scotland à Waverley Court 4 East Market Street Edinburgh EH8 8BG le 19 juin 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Miss Katherine Rosa Campbell en tant qu'administrateur le 27 mars 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gavin Knight Barrie en tant que directeur le 14 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTON, Danny, Councillor | Administrateur | King's Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 | Scotland | British | 325030770001 | |||||
| CAMERON, Lezley Marion, Cllr | Administrateur | c/o City Of Edinburgh Council 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 77460160001 | |||||
| WHYTE, Iain, Cllr | Administrateur | High Street EH1 1YJ Edinburgh City Chambers Scotland | Scotland | British | 148139080002 | |||||
| POWRIE, David Ernest | Secrétaire | Kilmarnock Road G41 3JE Glasgow 181 | British | 129989040001 | ||||||
| WILSON, Mary | Secrétaire | 3 Belgrave Road EH12 6NG Edinburgh | British | 42188180001 | ||||||
| BURNESS LLP | Secrétaire | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||
| BURNESS SOLICITORS | Secrétaire désigné | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 900000240001 | |||||||
| CHARLOTTE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2ET Edinburgh Midlothian | 65770370001 | |||||||
| ADAIR, Eric Weir | Administrateur | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 116185430001 | |||||
| ANDERSON, David Alexander | Administrateur | 24 Barclay Drive G84 9RB Helensburgh Argyll & Bute Uk | Scotland | British | 60610420002 | |||||
| BARRIE, Gavin Knight | Administrateur | The City Of Edinburgh Council City Chambers, High Street EH1 1YJ Edinburgh Rm 7.30 Scotland | Scotland | British | 206373190001 | |||||
| BENSON, Deborah Clare, Dr | Administrateur | Dolphinton EH46 7AF West Linton White Hill Estate Peeblesshire Scotland | United Kingdom | British | 52845300006 | |||||
| BUCHANAN, Tom | Administrateur | c/o City Chambers High Street EH1 1YJ Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 123330960001 | |||||
| CAMERON, Lezley Marion, Cllr | Administrateur | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | Scotland | British | 77460160001 | |||||
| CAMPBELL, Katherine Rosa | Administrateur | 4 East Market Street EH8 8BG Edinburgh Waverley Court Scotland | United Kingdom | British | 233686000001 | |||||
| CARDOWNIE, Stephen Archibald | Administrateur | 30 Bellevue Terrace EH7 4DS Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 122966850001 | |||||
| CRICHTON, David | Administrateur | St Peter's Hall 34 Main Street EH31 2AA Gullane East Lothian | Scotland | British | 102111000001 | |||||
| DAY, Cameron Blyth, Cllr | Administrateur | High Street EH1 1YJ Edinburgh City Chambers Scotland | United Kingdom | British | 154799320001 | |||||
| DUNN, Hugh John | Administrateur | c/o Waverley Court East Market Street EH8 8BG Edinburgh 4 United Kingdom | Scotland | British | 124746760001 | |||||
| DUNN, Hugh John | Administrateur | 33 Waverley Crescent Cumbernauld G67 4BG Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 124746760001 | |||||
| FANNING, John Paul | Administrateur | 2f2, 19 Montpelier Park EH10 4LX Edinburgh | Scotland | British | 97621190001 | |||||
| FITZPATRICK, William | Administrateur | 58 Royston Mains Crescent EH5 1LL Edinburgh | Scotland | Scottish | 44047510001 | |||||
| GALLAGHER, Stephen John | Administrateur | 7 Dornoch Way West Craigs G72 0GR High Blantyre | United Kingdom | British | 109295690001 | |||||
| HINDS, Lesley Adelaide | Administrateur | 4 Easter Drylaw Place EH4 2QD Edinburgh Lothian | Scotland | British | 3480180001 | |||||
| HOTCHKISS, Isla Janet Mackay | Administrateur | 21 Craigmount Gardens EH12 8EB Edinburgh | British | 88796040001 | ||||||
| HUNTER, Colin Ian | Administrateur | Stonelaws Farm EH40 3DX East Linton East Lothian | Scotland | British | 37329910003 | |||||
| JACKSON, Allan George | Administrateur | c/o City Chambers High Street EH1 1YJ Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 1281700001 | |||||
| LEWIS, Paul Dominic | Administrateur | 144 Craigleith Road EH4 2EQ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 80689030001 | |||||
| MACLEAN, Fiona Anne Craig | Administrateur | 7 Ethel Terrace EH10 5NB Edinburgh | British | 73314290001 | ||||||
| MAGINNIS, Elizabeth, Councillor | Administrateur | 2 Grierson Avenue EH5 2AP Edinburgh Scotland | British | 9512960001 | ||||||
| MCFARLANE, James Mclean Henderson | Administrateur | 13 St. Andrews Street EH39 4NU North Berwick East Lothian | British | 93222200002 | ||||||
| MCGOUGAN, CPFA, Donald Mcdougall | Administrateur | Greenbank Rise EH10 5RW Edinburgh 14 | Great Britain | British | 42737770002 | |||||
| MCINTYRE, James | Administrateur | 29 Dunbar Road EH41 3PN Haddington East Lothian | British | 68840740001 | ||||||
| MEAGHER, Jane | Administrateur | King's Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 | Scotland | British | 297865380001 | |||||
| MORRIS, Elaine Patricia, Councillor | Administrateur | c/o City Chambers High Street EH1 1YJ Edinburgh 1 United Kingdom | Scotland | British | 122961720001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Edi Group Limited | 30 juin 2016 | East Market Street EH8 8BG Edinburgh 4 Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
WATERFRONT EDINBURGH LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Créé le 11 févr. 2013 Livré le 21 févr. 2013 | En cours | Montant garanti £250,000 | |
Brèves mentions Area of ground lying to the south of waterfront avenue granton edinburgh MID74480. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 28 mai 2009 Livré le 02 juin 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 27 févr. 2008 Livré le 11 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Subjects at granton, edinburgh MID2 MID41993. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 27 avr. 2004 Livré le 15 mai 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The subjects on the south side of west harbour road, granton (title number MID2) and that area of ground near shore road, granton. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 07 nov. 2002 Livré le 14 nov. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of the personal bond dated 8 and 11 march 2002 | |
Brèves mentions Subjects on the south side of west harbour road, granton, edinburgh...see microfiche for full description. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 20 mars 2002 Livré le 26 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 1) subjects at west harbour road, west shore road, and west granton road, granton, edinburgh 2)318 west granton road, edinburggh (b) 320 west granton road, edinburgh (c) east house, 324 west granton road, edinburgh (d) 322 west granton road, edinburgh and (e) 326 west granton road, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 11 mars 2002 Livré le 25 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 11 déc. 2001 Livré le 19 déc. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti The balance of the premium under the terms of the agreement | |
Brèves mentions Edinburgh cold store at 28 west harbour road, granton, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 19 avr. 2001 Livré le 10 mai 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 08 déc. 2000 Livré le 20 déc. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Areas of ground at granton park avenue, edinburgh. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
WATERFRONT EDINBURGH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0