WATERFRONT EDINBURGH LIMITED

WATERFRONT EDINBURGH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWATERFRONT EDINBURGH LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC200223
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Titanium 1 King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LOTHIAN FIFTY (612) LIMITED27 sept. 199927 sept. 1999

    Quels sont les derniers comptes de WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2022
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au27 sept. 2023
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation11 oct. 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au27 sept. 2022
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Councillor Lezley Marion Cameron en tant qu'administrateur le 06 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jane Meagher en tant que directeur le 24 févr. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Councillor Danny Aston en tant qu'administrateur le 27 juin 2024

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Waverley Court 4 East Market Street Edinburgh EH8 8BG Scotland à Titanium 1 King's Inch Place Renfrew PA4 8WF le 07 déc. 2022

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 02 déc. 2022

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2021

    22 pagesAA

    Nomination de Councillor Jane Meagher en tant qu'administrateur le 30 juin 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Lezley Marion Cameron en tant que directeur le 30 juin 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Katherine Rosa Campbell en tant que directeur le 30 juin 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020

    22 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Lezley Marion Cameron le 16 sept. 2021

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018

    23 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 sept. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des détails de The Edi Group Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 juin 2018

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Eric Weir Adair en tant que directeur le 30 juin 2018

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017

    25 pagesAA

    Cessation de la nomination de Hugh Alexander Rutherford en tant que directeur le 30 mai 2018

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 3 Cockburn Street Edinburgh EH1 1QB Scotland à Waverley Court 4 East Market Street Edinburgh EH8 8BG le 19 juin 2018

    1 pagesAD01

    Nomination de Miss Katherine Rosa Campbell en tant qu'administrateur le 27 mars 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gavin Knight Barrie en tant que directeur le 14 mars 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ASTON, Danny, Councillor
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    Administrateur
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    ScotlandBritish325030770001
    CAMERON, Lezley Marion, Cllr
    c/o City Of Edinburgh Council
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Administrateur
    c/o City Of Edinburgh Council
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritish77460160001
    WHYTE, Iain, Cllr
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    City Chambers
    Scotland
    Administrateur
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    City Chambers
    Scotland
    ScotlandBritish148139080002
    POWRIE, David Ernest
    Kilmarnock Road
    G41 3JE Glasgow
    181
    Secrétaire
    Kilmarnock Road
    G41 3JE Glasgow
    181
    British129989040001
    WILSON, Mary
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Secrétaire
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    British42188180001
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire désigné
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    CHARLOTTE SECRETARIES LIMITED
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2ET Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2ET Edinburgh
    Midlothian
    65770370001
    ADAIR, Eric Weir
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Administrateur
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritish116185430001
    ANDERSON, David Alexander
    24 Barclay Drive
    G84 9RB Helensburgh
    Argyll & Bute
    Uk
    Administrateur
    24 Barclay Drive
    G84 9RB Helensburgh
    Argyll & Bute
    Uk
    ScotlandBritish60610420002
    BARRIE, Gavin Knight
    The City Of Edinburgh Council
    City Chambers, High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    Rm 7.30
    Scotland
    Administrateur
    The City Of Edinburgh Council
    City Chambers, High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    Rm 7.30
    Scotland
    ScotlandBritish206373190001
    BENSON, Deborah Clare, Dr
    Dolphinton
    EH46 7AF West Linton
    White Hill Estate
    Peeblesshire
    Scotland
    Administrateur
    Dolphinton
    EH46 7AF West Linton
    White Hill Estate
    Peeblesshire
    Scotland
    United KingdomBritish52845300006
    BUCHANAN, Tom
    c/o City Chambers
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o City Chambers
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish123330960001
    CAMERON, Lezley Marion, Cllr
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Administrateur
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    ScotlandBritish77460160001
    CAMPBELL, Katherine Rosa
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    Administrateur
    4 East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    Waverley Court
    Scotland
    United KingdomBritish233686000001
    CARDOWNIE, Stephen Archibald
    30 Bellevue Terrace
    EH7 4DS Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    30 Bellevue Terrace
    EH7 4DS Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish122966850001
    CRICHTON, David
    St Peter's Hall
    34 Main Street
    EH31 2AA Gullane
    East Lothian
    Administrateur
    St Peter's Hall
    34 Main Street
    EH31 2AA Gullane
    East Lothian
    ScotlandBritish102111000001
    DAY, Cameron Blyth, Cllr
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    City Chambers
    Scotland
    Administrateur
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    City Chambers
    Scotland
    United KingdomBritish154799320001
    DUNN, Hugh John
    c/o Waverley Court
    East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    4
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Waverley Court
    East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    4
    United Kingdom
    ScotlandBritish124746760001
    DUNN, Hugh John
    33 Waverley Crescent
    Cumbernauld
    G67 4BG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    33 Waverley Crescent
    Cumbernauld
    G67 4BG Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish124746760001
    FANNING, John Paul
    2f2, 19 Montpelier Park
    EH10 4LX Edinburgh
    Administrateur
    2f2, 19 Montpelier Park
    EH10 4LX Edinburgh
    ScotlandBritish97621190001
    FITZPATRICK, William
    58 Royston Mains Crescent
    EH5 1LL Edinburgh
    Administrateur
    58 Royston Mains Crescent
    EH5 1LL Edinburgh
    ScotlandScottish44047510001
    GALLAGHER, Stephen John
    7 Dornoch Way
    West Craigs
    G72 0GR High Blantyre
    Administrateur
    7 Dornoch Way
    West Craigs
    G72 0GR High Blantyre
    United KingdomBritish109295690001
    HINDS, Lesley Adelaide
    4 Easter Drylaw Place
    EH4 2QD Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    4 Easter Drylaw Place
    EH4 2QD Edinburgh
    Lothian
    ScotlandBritish3480180001
    HOTCHKISS, Isla Janet Mackay
    21 Craigmount Gardens
    EH12 8EB Edinburgh
    Administrateur
    21 Craigmount Gardens
    EH12 8EB Edinburgh
    British88796040001
    HUNTER, Colin Ian
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    Administrateur
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    ScotlandBritish37329910003
    JACKSON, Allan George
    c/o City Chambers
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o City Chambers
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish1281700001
    LEWIS, Paul Dominic
    144 Craigleith Road
    EH4 2EQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    144 Craigleith Road
    EH4 2EQ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish80689030001
    MACLEAN, Fiona Anne Craig
    7 Ethel Terrace
    EH10 5NB Edinburgh
    Administrateur
    7 Ethel Terrace
    EH10 5NB Edinburgh
    British73314290001
    MAGINNIS, Elizabeth, Councillor
    2 Grierson Avenue
    EH5 2AP Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    2 Grierson Avenue
    EH5 2AP Edinburgh
    Scotland
    British9512960001
    MCFARLANE, James Mclean Henderson
    13 St. Andrews Street
    EH39 4NU North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    13 St. Andrews Street
    EH39 4NU North Berwick
    East Lothian
    British93222200002
    MCGOUGAN, CPFA, Donald Mcdougall
    Greenbank Rise
    EH10 5RW Edinburgh
    14
    Administrateur
    Greenbank Rise
    EH10 5RW Edinburgh
    14
    Great BritainBritish42737770002
    MCINTYRE, James
    29 Dunbar Road
    EH41 3PN Haddington
    East Lothian
    Administrateur
    29 Dunbar Road
    EH41 3PN Haddington
    East Lothian
    British68840740001
    MEAGHER, Jane
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    Administrateur
    King's Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    ScotlandBritish297865380001
    MORRIS, Elaine Patricia, Councillor
    c/o City Chambers
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o City Chambers
    High Street
    EH1 1YJ Edinburgh
    1
    United Kingdom
    ScotlandBritish122961720001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WATERFRONT EDINBURGH LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Edi Group Limited
    East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    4
    Scotland
    30 juin 2016
    East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    4
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementScotland
    Numéro d'enregistrementSc110956
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    WATERFRONT EDINBURGH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 11 févr. 2013
    Livré le 21 févr. 2013
    En cours
    Montant garanti
    £250,000
    Brèves mentions
    Area of ground lying to the south of waterfront avenue granton edinburgh MID74480.
    Personnes ayant droit
    • The Edi Group Limited
    Transactions
    • 21 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Floating charge
    Créé le 28 mai 2009
    Livré le 02 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The City of Edinburgh Council
    Transactions
    • 02 juin 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 févr. 2008
    Livré le 11 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at granton, edinburgh MID2 MID41993.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 mars 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 avr. 2004
    Livré le 15 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects on the south side of west harbour road, granton (title number MID2) and that area of ground near shore road, granton.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 nov. 2002
    Livré le 14 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 8 and 11 march 2002
    Brèves mentions
    Subjects on the south side of west harbour road, granton, edinburgh...see microfiche for full description.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 nov. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 mars 2002
    Livré le 26 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1) subjects at west harbour road, west shore road, and west granton road, granton, edinburgh 2)318 west granton road, edinburggh (b) 320 west granton road, edinburgh (c) east house, 324 west granton road, edinburgh (d) 322 west granton road, edinburgh and (e) 326 west granton road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 mars 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 11 mars 2002
    Livré le 25 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mars 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 déc. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The balance of the premium under the terms of the agreement
    Brèves mentions
    Edinburgh cold store at 28 west harbour road, granton, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Alpine Cold Stores (Edinburgh) Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 19 avr. 2001
    Livré le 10 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 10 mai 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 08 déc. 2000
    Livré le 20 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Areas of ground at granton park avenue, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • United Wire Limited
    Transactions
    • 20 déc. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    WATERFRONT EDINBURGH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 déc. 2022Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0