NORTH AYRSHIRE LEISURE LIMITED

NORTH AYRSHIRE LEISURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTH AYRSHIRE LEISURE LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC202978
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTH AYRSHIRE LEISURE LIMITED ?

    • Exploitation d'installations sportives (93110) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement
    • Installations de fitness (93130) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement
    • Autres activités sportives (93199) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement
    • Activités de bien-être physique (96040) / Autres activités de services

    Où se situe NORTH AYRSHIRE LEISURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    22 Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NORTH AYRSHIRE LEISURE LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NORTH AYRSHIRE LEISURE LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au10 janv. 2027
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation24 janv. 2027
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au10 janv. 2026
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTH AYRSHIRE LEISURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2026 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2025

    45 pagesAA

    Nomination de Paul Brodie en tant qu'administrateur le 25 sept. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Brian Macdonald en tant qu'administrateur le 25 sept. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Steven Anderson en tant qu'administrateur le 25 sept. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Euan Douglas Smith en tant qu'administrateur le 25 sept. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jim Montgomerie en tant que directeur le 23 oct. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ashley Naitby Pringle en tant que directeur le 01 avr. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Helen Campbell en tant que directeur le 01 avr. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Murdoch en tant que directeur le 01 avr. 2025

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2024

    45 pagesAA

    Deuxième dépôt pour la nomination de Ross Glover en tant qu'administrateur

    3 pagesRP04AP01

    Nomination de Ross Glover en tant qu'administrateur le 12 juin 2024

    2 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    13 juin 2024Second Filing The information on the form AP01 has been replaced by a second filing on 13/06/2024

    Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    53 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ian Murdoch en tant qu'administrateur le 20 juil. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Jean Mcclung en tant qu'administrateur le 20 juil. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Jim Montgomerie en tant qu'administrateur le 20 juil. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de John Sweeney en tant qu'administrateur le 20 juil. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2022

    54 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Garnet Kerr (Gary) Higgon en tant que directeur le 19 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Shaun Macaulay en tant que directeur le 05 mai 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Sweeney en tant que directeur le 05 mai 2022

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de NORTH AYRSHIRE LEISURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANDERSON, Steven
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    United KingdomBritish121148910001
    BRODIE, Paul
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    United KingdomBritish342553260001
    GLOVER, Ross
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    United KingdomBritish323986280001
    MACDONALD, Brian
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    United KingdomBritish218466520001
    MCCLUNG, Jean
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    United KingdomBritish264846760001
    SMITH, Euan Douglas
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    United KingdomBritish289747330001
    SWEENEY, John
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    United KingdomBritish304640820001
    TODD, Anne Maria
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    ScotlandBritish259924440001
    TULLOCH, Lorraine Elizabeth
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    ScotlandBritish169814060001
    CAIRNS, Elizabeth
    Lymekilns Road
    Stewartfield
    G74 4TU East Kilbride
    82
    Secrétaire
    Lymekilns Road
    Stewartfield
    G74 4TU East Kilbride
    82
    British90805840002
    CHARLOTTE SECRETARIES LIMITED
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2ET Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2ET Edinburgh
    Midlothian
    65770370001
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Secrétaire désigné
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    ANDERSON, David Mclean
    17 First Avenue
    Netherlee
    G44 3UA Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    17 First Avenue
    Netherlee
    G44 3UA Glasgow
    Lanarkshire
    Scotland
    British90262590001
    BARR, Thomas
    35 Quarry Road
    KA12 0TN Irvine
    Ayrshire
    Administrateur
    35 Quarry Road
    KA12 0TN Irvine
    Ayrshire
    ScotlandBritish65607930001
    BILLINGS, Timothy John
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    ScotlandBritish216535700002
    BRAHIM, Joy
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    ScotlandDutch234583700001
    BURNS, Marie Agnes, Councillor
    Byrehill Drive
    West Byrehill Industrial Estate
    KA13 6HN Kilwinning
    Montgomerie House
    Scotland
    Administrateur
    Byrehill Drive
    West Byrehill Industrial Estate
    KA13 6HN Kilwinning
    Montgomerie House
    Scotland
    ScotlandBritish163290600001
    BURT, John
    74 Blairafton Wynd
    KA13 6UD Kilwinning
    Ayrshire
    Administrateur
    74 Blairafton Wynd
    KA13 6UD Kilwinning
    Ayrshire
    British84838730001
    BUSSELL, Joanna Margaret
    23 Queens Road
    Mortlake
    SW14 8PH London
    Administrateur
    23 Queens Road
    Mortlake
    SW14 8PH London
    EnglandBritish153241620001
    CAMPBELL, Helen
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    ScotlandBritish226009720001
    CHAMBERLAIN, Andrew
    Main Street
    KA13 6AA Kilwinning
    112 The Attic Flat
    Ayrshire
    Scotland
    Administrateur
    Main Street
    KA13 6AA Kilwinning
    112 The Attic Flat
    Ayrshire
    Scotland
    Scotland UkBritish161319290001
    CLARKSON, Ian
    Byrehill Drive
    West Byrehill Industrial Estate
    KA13 6HN Kilwinning
    Montgomerie House
    Scotland
    Administrateur
    Byrehill Drive
    West Byrehill Industrial Estate
    KA13 6HN Kilwinning
    Montgomerie House
    Scotland
    ScotlandBritish69091840001
    COWAN, William
    75 Bank Street
    KA12 0LL Irvine
    Administrateur
    75 Bank Street
    KA12 0LL Irvine
    British82075900001
    DEVINE, Bernard
    3a Corsehill Drive
    KA23 9HU West Kilbride
    Ayrshire
    Administrateur
    3a Corsehill Drive
    KA23 9HU West Kilbride
    Ayrshire
    British69460500001
    DEWAR, Stewart
    7 Pladda Wynd
    KA11 1DR Irvine
    Ayrshire
    Administrateur
    7 Pladda Wynd
    KA11 1DR Irvine
    Ayrshire
    British54104610001
    FRECKLETON, William
    35 West Road
    KA12 8RE Irvine
    Ayrshire
    Administrateur
    35 West Road
    KA12 8RE Irvine
    Ayrshire
    British87400070001
    FULTON, Barry
    2 Castleview
    Dundonald
    KA2 9HZ Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    2 Castleview
    Dundonald
    KA2 9HZ Kilmarnock
    Ayrshire
    British69332510001
    GARDINER, Brian
    3 Ramsay Crescent
    PA10 2AZ Kilbarchan
    Renfrewshire
    Administrateur
    3 Ramsay Crescent
    PA10 2AZ Kilbarchan
    Renfrewshire
    British52901000001
    HERBERT, Alasdair James
    8 Moredun Drive
    PA2 9LW Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    8 Moredun Drive
    PA2 9LW Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandBritish66562580001
    HIGGON, John Garnet Kerr (Gary)
    25 Diddup Drive
    KA20 4AF Stevenston
    Ayrshire
    Administrateur
    25 Diddup Drive
    KA20 4AF Stevenston
    Ayrshire
    ScotlandBritish94169220001
    HIGHET, Margaret Graham
    26 Sinclair Drive
    KA30 9BL Largs
    Ayrshire
    Administrateur
    26 Sinclair Drive
    KA30 9BL Largs
    Ayrshire
    British52980390001
    LAMB, Brian
    41 Milgarholm Avenue
    KA12 0EL Irvine
    Ayrshire
    Scotland
    Administrateur
    41 Milgarholm Avenue
    KA12 0EL Irvine
    Ayrshire
    Scotland
    United KingdomBritish951360002
    LAMB, John Gray
    97 Ardrossan Road
    Seamill
    KA23 9NF West Kilbride
    Ayrshire
    Administrateur
    97 Ardrossan Road
    Seamill
    KA23 9NF West Kilbride
    Ayrshire
    ScotlandBritish69243460001
    MACAULAY, Shaun
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    Administrateur
    Quarry Road
    KA12 0TH Irvine
    22
    Scotland
    ScotlandBritish236883450001
    MADSEN, Johan
    43 Woodside Road
    KA15 2BU Beith
    Ayrshire
    Administrateur
    43 Woodside Road
    KA15 2BU Beith
    Ayrshire
    Danish69243490001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour NORTH AYRSHIRE LEISURE LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    10 janv. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0