SIGNATURE KITCHENS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSIGNATURE KITCHENS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC213942
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SIGNATURE KITCHENS LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe SIGNATURE KITCHENS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Regency House Crossgates Road
    Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline
    Fife
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SIGNATURE KITCHENS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ANDSTRAT (NO.122) LIMITED19 déc. 200019 déc. 2000

    Quels sont les derniers comptes de SIGNATURE KITCHENS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour SIGNATURE KITCHENS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Vary loan agreement 22/11/2011
    RES13

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mars 2011

    État du capital au 03 mars 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    17 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Colin Edward Lewis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Dominic Lavelle en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robin Johnson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Joanne Elizabeth Massey en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Modification des coordonnées du secrétaire Robin Simon Johnson le 24 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dominic Joseph Lavelle le 06 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 13 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    20 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    20 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    33 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Section 175(5)(a)/groups specific conflict 01/09/2009
    RES13

    legacy

    10 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de SIGNATURE KITCHENS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808760001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050002
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesBritishDirector59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    BritishDirector75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MILLER, Alasdair James
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    Secrétaire
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    British200739750001
    PARSLIFFE, Andrew John
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    Secrétaire
    7 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Perthshire
    British67033440002
    ANDERSON STRATHERN WS
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Midlothian
    900020500001
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    BURNESS SOLICITORS
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire désigné
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900000240001
    BROWN, Simon Thomas David
    2 Laverockbank Road
    EH5 3DG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    2 Laverockbank Road
    EH5 3DG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishSolicitor118942920001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritishDirector9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishDirector35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritishDirector75350600002
    INGRAM, David Colin
    Bridleways
    Woodcote Green Road
    KT18 7DN Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Bridleways
    Woodcote Green Road
    KT18 7DN Epsom
    Surrey
    BritishAccountant109149390001
    KERR, John Neilson
    5 Craigleith Hill
    EH4 2EF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Craigleith Hill
    EH4 2EF Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor65694070001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MOTION, Michelle Hunter
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    Administrateur
    11 Curlew Brae
    EH54 6UG Livingston
    United KingdomBritishAccountant78545300002
    O'CALLAGHAN, Sean James
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    Administrateur
    3 Golf Place
    DD8 4TY Kirriemuir
    Angus
    BritishManaging Director Designate101412420001
    PUNLER, Keith Arthur
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    Administrateur
    Beaufield
    Middle Balado
    KY13 0NH Kinross
    Tayside
    ScotlandBritishChartered Surveyor142078700006
    SNEDDON, Lisa Marion
    2 Booth Place
    FK1 1BA Falkirk
    Stirlingshire
    Administrateur
    2 Booth Place
    FK1 1BA Falkirk
    Stirlingshire
    BritishSales Director101413820001

    SIGNATURE KITCHENS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 28 sept. 2001
    Livré le 15 oct. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 oct. 2001Enregistrement d'une charge (410)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0